THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02480670 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Manchester Business Park 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IDEALFLOW LIMITED | 13. März 1990 | 13. März 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brandon Howard Leigh als Geschäftsführer am 13. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Andrew Bowie als Direktor am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Lang als Geschäftsführer am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Paul Plant als Direktor am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2017 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB United Kingdom zum One St Peter's Square Manchester M2 3DE geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL, Martyn John | Sekretär | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park United Kingdom | British | 118053870001 | ||||||
| BOWIE, Andrew | Geschäftsführer | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park | United Kingdom | British | 242173620001 | |||||
| PLANT, Simon Paul | Geschäftsführer | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | 69276710003 | |||||
| GRIMSDELL, Colin Raymond | Sekretär | Grayrigg Mill Hill Lane Winshill DE15 0BB Burton On Trent Staffordshire | British | 66708640004 | ||||||
| HUGGETT, Stephen Philip | Sekretär | Wendell Bourne Lane OX15 5PG Hook Norton Oxfordshire | British | 62609060002 | ||||||
| KING, Sarah Valerie | Sekretär | 14 Beech Road TN13 1YG Sevenoaks Kent | British | 39000000002 | ||||||
| LAW, Oi Meng | Sekretär | 12 Tottenhall Road Palmers Green N13 6HX London | British | 37118300001 | ||||||
| NEWMAN, Robert Neil | Sekretär | Flat 9 Clarence Apartments 2 Clarence Road St Helier JE2 4QT Jersey Channel Islands | British | 105883440001 | ||||||
| WILDING, Linda | Sekretär | Tangley Way Blackheath GU4 8QS Guildford Surrey | British | 41193380003 | ||||||
| AVIS, Alice Mary Cleoniki | Geschäftsführer | 12 Westbourne Park Villas Paddington W2 5EA London | England | British | 45853470003 | |||||
| CLARKE, John Alfred | Geschäftsführer | The Gables 9 Sandy Close SG14 2BB Hertford Hertfordshire | British | 3236750001 | ||||||
| GRAHAM, Daniel William | Geschäftsführer | Osprey House 5 Old Street CHANNEL St Helier Jersey Channel Islands | British | 24931920001 | ||||||
| GREEN, Debi | Geschäftsführer | 19 De Bohun Avenue Southgate N14 4PU London | United Kingdom | British | 202052320001 | |||||
| GRIMSDELL, Colin Raymond | Geschäftsführer | Grayrigg Mill Hill Lane Winshill DE15 0BB Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 66708640004 | |||||
| HOW, Christopher Gerard | Geschäftsführer | Smallhurst Farm Meg Lane Higher Sutton SK11 0LY Macclesfield Cheshire | England | British | 103679070002 | |||||
| HUGGETT, Stephen Philip | Geschäftsführer | Wendell Bourne Lane OX15 5PG Hook Norton Oxfordshire | British | 62609060002 | ||||||
| LANG, Jon | Geschäftsführer | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park United Kingdom | England | British | 160382080001 | |||||
| LEIGH, Brandon Howard | Geschäftsführer | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | 127526610001 | |||||
| MURRAY, Ann | Geschäftsführer | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | 151614630001 | |||||
| NEWMAN, Robert Neil | Geschäftsführer | Flat 9 Clarence Apartments 2 Clarence Road St Helier JE2 4QT Jersey Channel Islands | Channel Islands | British | 105883440001 | |||||
| SAMPSON, Helena Ruth | Geschäftsführer | Mortlake Road TW9 4AS Kew 82 | United Kingdom | British | 136837940001 | |||||
| SIMS, Susan Mary | Geschäftsführer | The End Barn Buckland HP22 5HU Aylesbury | British | 16027700003 | ||||||
| WHEWAY, Allan James | Geschäftsführer | Westhaven Chesham Road Wigginton HP23 6JD Tring Hertfordshire | British | 16361590001 | ||||||
| WHEWAY, Tanya Maureen | Geschäftsführer | Westhaven Chesham Road Wigginton HP23 6JD Tring Hertfordshire | England | British | 16361600001 | |||||
| WILDING, Linda | Geschäftsführer | Tangley Way Blackheath GU4 8QS Guildford Surrey | England | British | 41193380003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz Cussons (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | 3500 Aviator Way M22 5TG Manchester Manchester Business Park United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THE SANCTUARY AT COVENT GARDEN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and security agreement | Erstellt am 08. Juli 2005 Geliefert am 27. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any principal debtor to the investor finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H floral street covent garden london (commercial premises at 11/12 floral street (excluding ground floor retail units) and premises in the basement), the rear of 40,41 and 43 king street covent garden, on the ground floor at the rear of 41 & 42 king street covent garden all properties and property interests equipment securities intellectual property insurance policies debts accounts pension fund interests goodwill & uncalled capital other rights benefit of the assigned documents floating charge all undertaking property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 2005 Geliefert am 13. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Jan. 2002 Geliefert am 18. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property at 11-12 floral street (excluding ground floor retail units basement & rear 40,41 & 43 king street & ground floor rear 41-42 king street, london, WC2.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 13. Dez. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Nov. 1996 Geliefert am 29. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly k/a idealflow limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 09. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The ordinary shares of £1 each of the sanctuary limited including all allotments accretions benefits and advantages whatsoever accruing in respect of such shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 09. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Two ordinary shares of £1 each of the sanctuary gym limited including all allotments accretions benefits and advantages whatsoever accruing in respect of such shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 09. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Two ordinary shares of £1 each of the sanctuary marketing limited including all allotments accretions benefits and advantages whatsoever accruing in respect of such shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 09. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0