MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED

MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02482440
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED?

    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    FRP ADVISORY LLP
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Hazelaw Secretaries Limited als Sekretär am 10. Okt. 2016

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 18. Aug. 2016

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Feb. 2016

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    21 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4-6 Williams Way Wollaston Northamptonshire NN29 7RQ zum 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham West Midlands B3 2HB am 28. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 03. Juni 2015

    • Kapital: GBP 5,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    3 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 024824400006, erstellt am 06. März 2015

    39 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von John David Keating als Geschäftsführer am 03. März 2015

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 31. Mai 2014

    • Kapital: GBP 5,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    USHER, Gary Robert
    Church Cottage Hickmire
    Wollaston
    NN29 7SL Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Church Cottage Hickmire
    Wollaston
    NN29 7SL Wellingborough
    Northamptonshire
    EnglandBritish46383270002
    APPLEBY, Stuart Gordon
    Clarendon Court
    Over Wallop
    SO20 8HU Stockbridge
    Hampshire
    Sekretär
    Clarendon Court
    Over Wallop
    SO20 8HU Stockbridge
    Hampshire
    British32077830001
    COATES, Marie Christina
    Unit 6 Quay Lane
    Hardway
    PO12 4LJ Gosport
    Hampshire
    Sekretär
    Unit 6 Quay Lane
    Hardway
    PO12 4LJ Gosport
    Hampshire
    British27651760001
    COATES, Terence James
    74 Fleet End Road
    Warsash
    SO31 9JG Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    74 Fleet End Road
    Warsash
    SO31 9JG Southampton
    Hampshire
    British11383570001
    HAZELAW SECRETARIES LIMITED
    Over Wallop
    SO20 8HU Stockbridge
    Clarendon Court
    Hampshire
    England
    Sekretär
    Over Wallop
    SO20 8HU Stockbridge
    Clarendon Court
    Hampshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1436369
    60862070001
    BIGNELL, Martin John Philip
    14 St Davids Road
    Locksheath
    SO31 6EP Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    14 St Davids Road
    Locksheath
    SO31 6EP Southampton
    Hampshire
    British11383580002
    COATES, Terence James
    74 Fleet End Road
    Warsash
    SO31 9JG Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    74 Fleet End Road
    Warsash
    SO31 9JG Southampton
    Hampshire
    British11383570001
    KEATING, John David
    Beaulieu Road
    SO43 7DA Lynhurst
    Okefield Lodge
    Hants
    England
    Geschäftsführer
    Beaulieu Road
    SO43 7DA Lynhurst
    Okefield Lodge
    Hants
    England
    EnglandBritish8367700003
    NASH, Peter Lee
    28 Victory Avenue
    PO8 9PJ Waterlooville
    Hampshire
    Geschäftsführer
    28 Victory Avenue
    PO8 9PJ Waterlooville
    Hampshire
    British46383320003
    OLIVER, Roy Arthur
    Romans Sarum Road
    SO22 5QE Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Romans Sarum Road
    SO22 5QE Winchester
    Hampshire
    British8367710002

    Hat MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 06. März 2015
    Geliefert am 06. März 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All monetary and all obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due owing or incurred by the company to or in favour of ultimate invoice finance limited, present or future, actual or contingent, liquidated or unliquidated, whether arising in or by contract, tort, restitution, assignment or breach of statutory duty and whether arising under the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company or otherwise including (without prejudice to that generality) any such liability of the company by virtue of any assignment to ultimate invoice finance limited of any indebtedness incurred or to be incurred by the company for any supply of any goods or services to or any hiring by the company.. 1. by way of first fixed charge:. A) the freehold and leasehold property of the company both present and future and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings;. B) all goodwill and unpaid/and/or uncalled capital of the company;. C) all stocks shares and securities and documents evidencing title to or the right to possession of any property at any time deposited with ultimate invoice finance limited and the property mentioned in such documents;. D) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company;. E) any debt (purchased or purported to be purchased by ultimate invoice finance limited pursuant to the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company), of which the ownership fails to vest absolutely and effectively in ultimate invoice finance limited for any reason, together with the related rights pertaining to such debt and the proceeds of it;. F) all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever (together with their proceeds and the related rights pertaining thereto);. G) all amounts now or hereafter owing or becoming due to the company by ultimate invoice finance limited including (but not limited to) any amount retained by ultimate invoice finance limited under any provision of the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ultimate Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 06. März 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Book debts debenture
    Erstellt am 10. Nov. 1995
    Geliefert am 13. Nov. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Juli 1992
    Geliefert am 15. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1991
    Geliefert am 13. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (1) unit 6, quay lane, hardway, gosport, hampshire. (2) fixed charge over the company's f/h and l/h property both present and future its uncalled and unpaid capital for the time being, stocks and shares or other securities held by the company & its goodwill. (3) floating charge over the undertaking and all its property and assets whatsoever.
    Berechtigte Personen
    • Mr Terry Coates.
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1991
    Geliefert am 13. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (1) unit 6 quay lane, hardway, gosport, hampshire. (2) fixed charge over the company's f/h and l/h property both present and future, its uncalled and unpaid and capital for the time being stocks and shares or other securities held by the company and its goodwill.(3) Floating charge over the company's undertaking and all its property and all its property and assets whatsoever.
    Berechtigte Personen
    • Mr. Martyn Bignell.
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Single debenture
    Erstellt am 18. Mai 1990
    Geliefert am 30. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 24. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MARTEL-WESSEX COMPOSITES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Aug. 2015Beginn der Verwaltung
    18. Aug. 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Martin Stokes
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Raj Mittal
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praktiker
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0