HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED

HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02486729
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OIL PROPERTY INVESTMENT LIMITED 08. Apr. 199208. Apr. 1992
    OSSORY INVESTMENTS LIMITED16. Aug. 199016. Aug. 1990
    ROCHDENE LIMITED29. März 199029. März 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 08. Okt. 2019

    • Kapital: GBP 1
    6 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    12 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Jordan Cosec Limited am 05. Apr. 2019

    1 SeitenCH04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    10 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    5 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VISTRA COSEC LIMITED
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Sekretär
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6412777
    128256230002
    DUGGINS, David Kenneth
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant241313890001
    FLANNERY, Paul Stephen
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector228336000001
    PIRIE, Grant Andrew Royston
    18 Snape View
    TN5 6BZ Wadhurst
    East Sussex
    Sekretär
    18 Snape View
    TN5 6BZ Wadhurst
    East Sussex
    BritishAccountant90837500002
    THAKER, Harin Jayantilal
    21 Dafforne Road
    Tooting
    SW17 8TY London
    Sekretär
    21 Dafforne Road
    Tooting
    SW17 8TY London
    British34972060001
    BALCH, Charles William Francis
    Hastings Road
    Rolvenden
    TN17 4PJ Cranbrook
    Cornhill
    Kent
    Geschäftsführer
    Hastings Road
    Rolvenden
    TN17 4PJ Cranbrook
    Cornhill
    Kent
    United KingdomBritishBanker134613570001
    BARAN, Tanja
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanPortfolio Management228335960001
    BARTHUBER, Reiner
    21st Floor 30 St Mary Axe
    London
    EC3A 8BF
    Geschäftsführer
    21st Floor 30 St Mary Axe
    London
    EC3A 8BF
    GermanyGermanNone153513990001
    BUSCH, Jan Lars-Hendrik
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanDirector201248160001
    COX, Nigel Alban
    Pine Tree Cottage 53 Chipstead Lane
    TN13 2AJ Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Pine Tree Cottage 53 Chipstead Lane
    TN13 2AJ Sevenoaks
    Kent
    BritishBanker29684280002
    DE GREIFF, Michael Juergen
    30 St Mary Axe
    EC3A 8BF London
    21st Floor
    England
    Geschäftsführer
    30 St Mary Axe
    EC3A 8BF London
    21st Floor
    England
    GermanyGermanNone166155590002
    FAATZ, Arndt, Dr
    BS1 6BU Bristol
    1 Mitchell Lane
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    BS1 6BU Bristol
    1 Mitchell Lane
    United Kingdom
    United KingdomGermanBarrister-At-Law202474760001
    FALKNER, Carola
    BS1 6BU Bristol
    1 Mitchell Lane
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    BS1 6BU Bristol
    1 Mitchell Lane
    United Kingdom
    GermanyGermanLawyer212995500001
    FENK, Juergen
    Niagra Villas
    Coliemore Road
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Niagra Villas
    Coliemore Road
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    GermanBanker103013690001
    FENK, Juergen
    Niagra Villas
    Coliemore Road
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Niagra Villas
    Coliemore Road
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    GermanBanker103013690001
    FLANNERY, Paul Stephen
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11-12 St. James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector228336000001
    FUNKE, Georg
    Aldwyn Lodge
    Old London Road, Knockholt
    TN14 7JW Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Aldwyn Lodge
    Old London Road, Knockholt
    TN14 7JW Sevenoaks
    Kent
    GermanProperty Finance13242190010
    HEISS, Klaus, Dr
    Berbestrasse 18
    D 81927 Munich
    Germany
    Geschäftsführer
    Berbestrasse 18
    D 81927 Munich
    Germany
    GermanDirector24548620001
    HUNTLEY, Andrew John Mack
    Ashurst
    Fernhurst
    GU27 3JB Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Ashurst
    Fernhurst
    GU27 3JB Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor2995330001
    LAMBY, Frank
    Gabriel-Von-Seidl-Strasse 2a
    Grunwald
    82031
    Germany
    Geschäftsführer
    Gabriel-Von-Seidl-Strasse 2a
    Grunwald
    82031
    Germany
    GermanBanker119269930001
    LAMBY, Frank
    Dr. Lindner Strasse 4a
    Gruenwald
    82031
    Germany
    Geschäftsführer
    Dr. Lindner Strasse 4a
    Gruenwald
    82031
    Germany
    GermanBanker96525470001
    LEHMANN, Frank Oliver
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Uk
    Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Uk
    GermanyGermanNone165963780001
    LUKER, Edward Thomas David
    Beetle Cottage Carthouse Lane
    Horsell
    GU21 4XT Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beetle Cottage Carthouse Lane
    Horsell
    GU21 4XT Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor17864370001
    MUENTE, Tobias
    BS1 6BU Bristol
    1 Mitchell Lane
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    BS1 6BU Bristol
    1 Mitchell Lane
    United Kingdom
    GermanyGermanDirector201248090001
    MULLER, Christoph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8BF London
    21st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    30 St Mary Axe
    EC3A 8BF London
    21st Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanNone156219780001
    PEREZ-DURANTEZ, Mariano
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Uk
    Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Uk
    GermanySpanishDirector192986970001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    BritishDirector94724020002
    SHAOUL, Joseph Michael
    20 Hazelmere Avenue
    Hale Barns
    WA15 0AU Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Hazelmere Avenue
    Hale Barns
    WA15 0AU Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector20145240001
    THAKER, Harin Jayantilal
    21 Dafforne Road
    Tooting
    SW17 8TY London
    Geschäftsführer
    21 Dafforne Road
    Tooting
    SW17 8TY London
    EnglandBritishAccountant34972060001
    WAGNER, Christoph Karl Josef, Dr
    21st Floor 30 St Mary Axe
    London
    EC3A 8BF
    Geschäftsführer
    21st Floor 30 St Mary Axe
    London
    EC3A 8BF
    GermanyGermanNone154975200001
    WHITE, Michael
    Malmains Oast
    Pluckley
    TN27 0SE Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Malmains Oast
    Pluckley
    TN27 0SE Ashford
    Kent
    BritishBanker77208610001
    WUEST, Rudolf, Dr
    Zugspitzstrasse 6
    8022 Gruenwald
    Germany
    Geschäftsführer
    Zugspitzstrasse 6
    8022 Gruenwald
    Germany
    GermanCompany Director29684310001
    PORTROE CONSULTING LIMITED
    101 New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Carlton House
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    101 New London Road
    CM2 0PP Chelmsford
    Carlton House
    Essex
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer10934860
    239399080001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Flint Nominees Limited
    Bedford Row
    WC1R 4JS London
    20-22
    England
    06. Apr. 2016
    Bedford Row
    WC1R 4JS London
    20-22
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House Uk
    Registrierungsnummer02669313
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat HYPO PROPERTY INVESTMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 13. Okt. 1998
    Geliefert am 30. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defiend) to the chargee under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage f/h interchange house capital interchange way brentford t/n-AGL28039. By way of first fixed charge all plant and machinery book and other debts; by way of floating charge all other assets not otherwise mortgaged or charged by way of fixed mortgage or charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaftas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined) (the "Agent")
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 31. März 1992
    Geliefert am 06. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the co. Howsoever arising whether under or in connection with a facility agreement d/d 28/2/92 the charge or otherwise
    Kurze Angaben
    F/H land on the south side of upper parliament street & on the east side of king street nottingham k/a fothergill house....see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank and/or Any Receiver
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 09. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under or in connection with a facility agreement d/D20/12/91, a deed of charge d/d 20/12/91 ("the principal deed), this deed of charge or otherwise
    Kurze Angaben
    The deposit & all rights & interests relating to the deposit...see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 28. Feb. 1992
    Geliefert am 07. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement and this charge
    Kurze Angaben
    Freehold land on the south side of upper parliament street in nottingham k/a express buildings title no nt 136707 freehold land situate at the junction of bristol road and chapel lane selly oak birmingham k/a battery park together with the buildings erected title no wm 476919 freehold land k/a 93-95 high street maidstone kent title no K186489 fixed plant and machinery and all rights and interests.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 07. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 20. Dez. 1991
    Geliefert am 31. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the co. To the bank and/or any receiver whether under or in connection with a facility agreement d/d 20/12/91, the deed of charge or otherwise
    Kurze Angaben
    The charged property & the deposit (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 13. Dez. 1991
    Geliefert am 23. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever see form 395 for full details
    Kurze Angaben
    Lease between lothian district council & newcraighall enterprises LTD.....see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 12. Dez. 1991
    Geliefert am 17. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee howsoever arising, whether under or in connection with the facility agreement d/d 10/10/91, this charge or otherwise
    Kurze Angaben
    All rights & interests whatsoever of the mortgagor relating to the deposit......(see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 29. Okt. 1991
    Geliefert am 01. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver (as defined) under the terms of the facility agreement dated 24/10/91, this charge or otherwise
    Kurze Angaben
    F/H property k/as interchange house. Capital intercharge way brentford london t/no: agl 25950 together with all buildings & fixtures. See 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken Und
    • Wechsel - Bank Ag
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 03. Okt. 1991
    Geliefert am 07. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver (as defined) under or in connection with the facility agreement dated 23/9/91, the charge or otherwise
    Kurze Angaben
    F/H property k/as goldsworth park district centre bampton way woking t/no: sy 534203 together with buildings & fixtures see 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 1991
    Geliefert am 31. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the facility agreement dated 15.7.91, this charge or otherwise
    Kurze Angaben
    All that l/hold property k/as derwent house retail park, derwent house, workington cumbria, together with all buildings erections, fixtures (but excluding all tenant's trade fixtures & fittings) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 31. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 1991
    Geliefert am 31. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the facility agreement dated 15.7.91, this charge or otherwise
    Kurze Angaben
    All the land and buildings at thanet way, whitstable f/hold title no. K 613595 together with all buildings, erections, fixtures (but excluding all tenant's trade fixtures & fittings) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 31. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 1991
    Geliefert am 31. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the facility agreement dated 15.7.91, this charge or otherwise
    Kurze Angaben
    All that f/hold property situate at pentrebach retail development site merthyr tydfil mid glamorgan together with all buildings erections, fixtures, (but excluding all tenants trade fixtures & fittings) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 31. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 12. Juli 1991
    Geliefert am 19. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under the terms of the facility agreement dated 5.7.91, this charge or otherwise
    Kurze Angaben
    F/Hold land (k/as the lucas industries building and k/formerly as factory no. Bt. 548/1) at sticker lane, bradford yorkshire title nos. Wyk 328612, wyk 270041, wyk 291321 and wyk 318271 together with all buildings, erections fixtures, fittings and fixed plant & machinery 2) by way of first legal mortgage free from encumbrances the deposit and all rights & interests whatsoever of the mortgager relating to the deposit.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 19. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 1991
    Geliefert am 03. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 03. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 04. Juni 1991
    Geliefert am 20. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold land and buildings k/as d concorde business park wyihenshawe manchester title no. Gm 567293 please see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank A.G
    Transaktionen
    • 20. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Mai 1991
    Geliefert am 05. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or arising in connection with a facility letter dated 31.5.91 and this charge.
    Kurze Angaben
    The real property (as defined). A fixed charge the benefit of all rights or claims floating charge over all please see 395 for full details. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Bayerisch Hypotheken Und Wechsel Bank A.G.
    Transaktionen
    • 05. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 06. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings k/as 8-10 great george street westminster london SW1 title no. Ln 177801 and interest in any insurance please see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerisch Hypothchenr Und Wechsel Bank A.G.
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 25. März 1991
    Geliefert am 04. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as cascades centre rotherham s yorkshire and interest in any insurance please see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Richard Ellis Financial Services Limited.
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 25. März 1991
    Geliefert am 04. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as cascodes centre rotherham s yorkshire and interest in any insurance please see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Weschel Bank Ag.
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    Fixed charge
    Erstellt am 25. März 1991
    Geliefert am 04. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold land & buildings k/as unit e concord business park theapwood road simonsway, wyehenshawe manchester and interest in any insurance please see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayersich Hypotheken Und Wechsel Bank Ag.
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 25. März 1991
    Geliefert am 04. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold land & buildings k/as unit e concord business park theapwood road simonsway, wyehenshawe manchester and interest in any insuracne plese see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Richard Ellis Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    Fixed charge
    Erstellt am 23. Jan. 1991
    Geliefert am 01. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold land and buildings west side of threapwood road wythenshawe manchester and other property in the area, please see schedule with 395 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Ricland Elles Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    Fixed charge
    Erstellt am 23. Jan. 1991
    Geliefert am 01. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold land and buildings west side of threapwood road wythenshawe manchster and other property in the area, please see sehedule with 395 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerisch Hypotheken Und Wechsel Bank Ag
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 05. Okt. 1990
    Geliefert am 13. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Richard Ellis Financial Services LTD
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    Floating charge
    Erstellt am 05. Okt. 1990
    Geliefert am 12. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    , both present & future benefit of all securities and guarantees. All monies from time to time. (See 395 for details).. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken Und Wechsel Bank Ag.
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. Feb. 1996Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 05. Apr. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0