BIRKBY'S PLASTICS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BIRKBY'S PLASTICS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02486780 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?
- (2416) /
Wo befindet sich BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o ERNST AND YOUNG LLP 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ROCHLANE LIMITED | 29. März 1990 | 29. März 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Apr. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 15 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2016 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2015 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2014 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Harrison & Co Enterprise Centre 1 Beeches Road Office No 7 West Bromwich West Midlands B70 6QE* am 13. Mai 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR* am 17. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Apr. 2013 | 26 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 2 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Okt. 2012 | 30 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 54 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 13 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Headlands Road Liversedge West Yorkshire WF15 6QA* am 02. Mai 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2011 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Nicola Jane Rose am 29. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Chaytor Parker am 29. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Moore am 29. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Macartan Flanagan am 29. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John David Miles Child am 29. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSE, Nicola Jane | Sekretär | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | British | Director | 126314740002 | |||||
CHILD, John David Miles | Geschäftsführer | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 127126380001 | ||||
FLANAGAN, Macartan Thomas | Geschäftsführer | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | Irish | Director | 126314750001 | ||||
MOORE, Thomas | Geschäftsführer | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | British | Director | 83054600001 | ||||
PARKER, Ian Chaytor | Geschäftsführer | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | British | Director | 126314710002 | ||||
ROSE, Nicola Jane | Geschäftsführer | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 126314740002 | ||||
SHELTON, Victor John | Geschäftsführer | c/o Ernst And Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Operations Director | 110663320001 | ||||
BULLIVANT, Andrew Richard | Sekretär | High Lees 4 Crowlees Road WF14 9PR Mirfield West Yorkshire | English | Secretary | 71336140002 | |||||
NAKAMURA, Hideo | Sekretär | 23 Southborough Road BR1 2EA Bickley Kent | Japanese | 1162300005 | ||||||
YASUE, Hideyuki | Sekretär | Flat 7 Chelsea Gate Apartments 93 Ebury Bridge Road SW1W 8RB London | British | Company Secretary | 47576020004 | |||||
BULLIVANT, Andrew Richard | Geschäftsführer | High Lees 4 Crowlees Road WF14 9PR Mirfield West Yorkshire | England | English | Secretary | 71336140002 | ||||
FUKAWA, Isao | Geschäftsführer | 3-420-1-201 Fujiwaracho FOREIGN Funabashi City Chiba Japan | Japanese | Director | 13280350001 | |||||
HAGIWARA, Nobuyuki | Geschäftsführer | 50 Regency Lodge Adelaide Road NW3 5ED London | Japanese | Director | 60385230001 | |||||
HANDS, Martin Jeffery | Geschäftsführer | Lindley House YO19 4RU Naburn North Yorkshire | England | British | Director | 151471980001 | ||||
HARRISON, Stephen | Geschäftsführer | Long Meadow 5 Farnley Hey Farnley Tyas HD4 6TY Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 84196630003 | ||||
HASHIMOTO, Sakae | Geschäftsführer | 21 Bentcliffe Avenue LS17 6QJ Leeds West Yorkshire | Japanese | Director | 13280360002 | |||||
HAYASAKI, Satoru | Geschäftsführer | 7 Kelsterne Close TS15 9SX Yarm Cleveland | Japanese | Alternate Director | 43920480001 | |||||
HORNE, John | Geschäftsführer | 48 Nab Lane WF14 9BQ Mirfield West Yorkshire | British | Director | 13280370001 | |||||
HUNTER, Ian | Geschäftsführer | Maingate House Maingate Hepworth HD9 1TJ Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 127869540001 | ||||
IBUKI, Yoshihiro | Geschäftsführer | 415 4-18-20 Mita Minato Ku FOREIGN Tokyo 108-0073 Japan | Japanese | Director | 82030950001 | |||||
IIDA, Kunihiko | Geschäftsführer | 1-15-202 Kashiwadai Inage-Ku Chiba | Japanese | Director | 30390320001 | |||||
ISHIMARU, Yuichi | Geschäftsführer | 18 Imperial Court 1 Avenue Road St Johns Wood NW8 7PT London | Japanese | Director | 57853960001 | |||||
JENKINS, Paul Robert | Geschäftsführer | 29 Dukewood Road Clayton West HD8 9HF Huddersfield West Yorkshire | British | Director | 43788130001 | |||||
JONES, Fiona | Geschäftsführer | 27 Avenue Clarmart DN15 8EQ Scunthorpe | United Kingdom | British | Director | 127128940001 | ||||
KAMIYA, Tetsuro | Geschäftsführer | 1-8-15 Isoko-Ku Yokohama Kanegawa Japan | Japanese | Director | 59385480001 | |||||
KANEDA, Satoshi | Geschäftsführer | 5 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JY London | Japanese | Alternate Director | 12338190002 | |||||
KASUGAI, Takaki | Geschäftsführer | Rue Langeveld 71 1180 Uccle FOREIGN Brussels Belgium | Japanese | Director | 13280400001 | |||||
KAWASHIMA, Hikoaki | Geschäftsführer | Niederrheinstr 18 4000 Dusseldorf Germany | Japanese | Director | 25960660001 | |||||
KITAOKA, Tetsuro | Geschäftsführer | 3-8-44 Izumi FOREIGN Suginami-Ku Tokyo Japan | Japanese | Director | 14961940003 | |||||
KOH, Katsuo | Geschäftsführer | 37-4-302 Nihonbashi Hakozakicho Chuo-Ku Tokyo Japan | Japanese | Director | 34805000001 | |||||
KOMATSU, Ichiro | Geschäftsführer | 18 Imperial Court 1 Avenue Road St Johns Wood NW8 9JY London | Japanese | Director | 52655340001 | |||||
KOMATSU, Masakazu | Geschäftsführer | 52 Ridge View Drive Birkby HD2 2EX Huddersfield West Yorkshire | Japanese | General Manager | 66606600002 | |||||
KUBO, Hirohiko | Geschäftsführer | Flat 32 Clarance Terrace Regents Park NM1 4RD London | Japanese | Director | 69412540003 | |||||
KURODA, Kenso | Geschäftsführer | 403 Imei Mansion 22 6 Kaki Uchi Imei Terato Cho Mukou Shi FOREIGN Kyoto Japan | Japanese | Director | 13280430002 | |||||
MAEDA, Shinichiro | Geschäftsführer | 29 Park Lane Roundhay LS8 2EX Leeds West Yorkshire | Japanese | Director | 25960670002 |
Hat BIRKBY'S PLASTICS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 20. Feb. 2012 Geliefert am 21. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re: birkby's plastics limited and numbered 00552864 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 11. Sept. 2009 Geliefert am 15. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A presma press s/no 3108/2009 together with all the mortgaged chattels. -. demag ergotech 650-3300, 650 tonne injesction moulder s/no 863-1213. toshiba IS850GT-81A 850 tonne injection moulder s/no 936612.. toshiba IS650GT 59A, 650 tonne injection moulder s/no 727801. (for further details of chattels charged please refer to form 395) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 02. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Two dmag 1400 t moulding machines of the following specification: R21-ergotech interenational 10000-8000, machine type vd 865 0018, E20-d-1800-12900 nciii, machine no. 834 0023 with full title guarantee charges by way of first fixed and floating charge all of its rights, title and interest see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Jan. 2008 Geliefert am 18. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 11. Jan. 2008 Geliefert am 17. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 11. Jan. 2008 Geliefert am 17. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 11. Jan. 2008 Geliefert am 16. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 14. Nov. 2007 Geliefert am 26. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Engel injection moulding machine duo 11050/1700 - s/no 160172, hinge arm robot (6 axis) kuka KR150L110 s/no 160144, engine injection moulding machine duo 11050/1700 -0 s/no 165781 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 31. März 2003 Geliefert am 07. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Imm 001 stork model: st-2500-440, 440 tonne horizontal cnc toggle type injection moulding machine with robotic unloader and related equipment, s/n 74524. imm 002 stork model: st-1600-440, 440 tonne horizontal cnc toggle type injection moulding machine with robotic unloader and related equipment, s/n 66403. imm 003 stork model: st-1600-440, 440 tonne horizontal cnc toggle type injection moulding machine with robotic unloader and related equipment, s/n 64413. for details of further chattels charged please refer to form 395, and all spare parts replacements modifications and addition and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 31. März 2003 Geliefert am 07. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n's WYK730016, WYK318877 and WYK735540. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 31. März 2003 Geliefert am 07. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n WYK730016. F/h land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n WYK318877. F/h land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n WYK735540.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All estates or interests in the f/h or l/h property at headlands road liversedge west yorkshire t/n WYK730016 and WKY735540 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on such property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Juli 2002 Geliefert am 04. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balances | Erstellt am 25. Nov. 1997 Geliefert am 10. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a deferment guarantee dated 11TH october 1996 in favour of h m customs & excise for £200,000 | |
Kurze Angaben The sum of £200,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 22224823 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BIRKBY'S PLASTICS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0