BIRKBY'S PLASTICS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBIRKBY'S PLASTICS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02486780
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?

    • (2416) /

    Wo befindet sich BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ERNST AND YOUNG LLP
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROCHLANE LIMITED29. März 199029. März 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Apr. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    15 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2016

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2015

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Apr. 2014

    17 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Harrison & Co Enterprise Centre 1 Beeches Road Office No 7 West Bromwich West Midlands B70 6QE* am 13. Mai 2014

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR* am 17. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Apr. 2013

    26 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    2 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Okt. 2012

    30 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    54 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    13 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Headlands Road Liversedge West Yorkshire WF15 6QA* am 02. Mai 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2011

    23 SeitenAA

    legacy

    7 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Apr. 2011

    Kapitalaufstellung am 01. Apr. 2011

    • Kapital: GBP 838,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Nicola Jane Rose am 29. März 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Chaytor Parker am 29. März 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Moore am 29. März 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Macartan Flanagan am 29. März 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John David Miles Child am 29. März 2011

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von BIRKBY'S PLASTICS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROSE, Nicola Jane
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Sekretär
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    BritishDirector126314740002
    CHILD, John David Miles
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector127126380001
    FLANAGAN, Macartan Thomas
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandIrishDirector126314750001
    MOORE, Thomas
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector83054600001
    PARKER, Ian Chaytor
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector126314710002
    ROSE, Nicola Jane
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector126314740002
    SHELTON, Victor John
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishOperations Director110663320001
    BULLIVANT, Andrew Richard
    High Lees
    4 Crowlees Road
    WF14 9PR Mirfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    High Lees
    4 Crowlees Road
    WF14 9PR Mirfield
    West Yorkshire
    EnglishSecretary71336140002
    NAKAMURA, Hideo
    23 Southborough Road
    BR1 2EA Bickley
    Kent
    Sekretär
    23 Southborough Road
    BR1 2EA Bickley
    Kent
    Japanese1162300005
    YASUE, Hideyuki
    Flat 7 Chelsea Gate Apartments
    93 Ebury Bridge Road
    SW1W 8RB London
    Sekretär
    Flat 7 Chelsea Gate Apartments
    93 Ebury Bridge Road
    SW1W 8RB London
    BritishCompany Secretary47576020004
    BULLIVANT, Andrew Richard
    High Lees
    4 Crowlees Road
    WF14 9PR Mirfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    High Lees
    4 Crowlees Road
    WF14 9PR Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandEnglishSecretary71336140002
    FUKAWA, Isao
    3-420-1-201
    Fujiwaracho
    FOREIGN Funabashi City
    Chiba
    Japan
    Geschäftsführer
    3-420-1-201
    Fujiwaracho
    FOREIGN Funabashi City
    Chiba
    Japan
    JapaneseDirector13280350001
    HAGIWARA, Nobuyuki
    50 Regency Lodge
    Adelaide Road
    NW3 5ED London
    Geschäftsführer
    50 Regency Lodge
    Adelaide Road
    NW3 5ED London
    JapaneseDirector60385230001
    HANDS, Martin Jeffery
    Lindley House
    YO19 4RU Naburn
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lindley House
    YO19 4RU Naburn
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector151471980001
    HARRISON, Stephen
    Long Meadow 5 Farnley Hey
    Farnley Tyas
    HD4 6TY Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Long Meadow 5 Farnley Hey
    Farnley Tyas
    HD4 6TY Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector84196630003
    HASHIMOTO, Sakae
    21 Bentcliffe Avenue
    LS17 6QJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    21 Bentcliffe Avenue
    LS17 6QJ Leeds
    West Yorkshire
    JapaneseDirector13280360002
    HAYASAKI, Satoru
    7 Kelsterne Close
    TS15 9SX Yarm
    Cleveland
    Geschäftsführer
    7 Kelsterne Close
    TS15 9SX Yarm
    Cleveland
    JapaneseAlternate Director43920480001
    HORNE, John
    48 Nab Lane
    WF14 9BQ Mirfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    48 Nab Lane
    WF14 9BQ Mirfield
    West Yorkshire
    BritishDirector13280370001
    HUNTER, Ian
    Maingate House
    Maingate Hepworth
    HD9 1TJ Holmfirth
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Maingate House
    Maingate Hepworth
    HD9 1TJ Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector127869540001
    IBUKI, Yoshihiro
    415 4-18-20 Mita
    Minato Ku
    FOREIGN Tokyo
    108-0073
    Japan
    Geschäftsführer
    415 4-18-20 Mita
    Minato Ku
    FOREIGN Tokyo
    108-0073
    Japan
    JapaneseDirector82030950001
    IIDA, Kunihiko
    1-15-202 Kashiwadai
    Inage-Ku
    Chiba
    Geschäftsführer
    1-15-202 Kashiwadai
    Inage-Ku
    Chiba
    JapaneseDirector30390320001
    ISHIMARU, Yuichi
    18 Imperial Court 1 Avenue Road
    St Johns Wood
    NW8 7PT London
    Geschäftsführer
    18 Imperial Court 1 Avenue Road
    St Johns Wood
    NW8 7PT London
    JapaneseDirector57853960001
    JENKINS, Paul Robert
    29 Dukewood Road
    Clayton West
    HD8 9HF Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    29 Dukewood Road
    Clayton West
    HD8 9HF Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector43788130001
    JONES, Fiona
    27 Avenue Clarmart
    DN15 8EQ Scunthorpe
    Geschäftsführer
    27 Avenue Clarmart
    DN15 8EQ Scunthorpe
    United KingdomBritishDirector127128940001
    KAMIYA, Tetsuro
    1-8-15 Isoko-Ku
    Yokohama
    Kanegawa
    Japan
    Geschäftsführer
    1-8-15 Isoko-Ku
    Yokohama
    Kanegawa
    Japan
    JapaneseDirector59385480001
    KANEDA, Satoshi
    5 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JY London
    Geschäftsführer
    5 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JY London
    JapaneseAlternate Director12338190002
    KASUGAI, Takaki
    Rue Langeveld 71
    1180 Uccle
    FOREIGN
    Brussels
    Belgium
    Geschäftsführer
    Rue Langeveld 71
    1180 Uccle
    FOREIGN
    Brussels
    Belgium
    JapaneseDirector13280400001
    KAWASHIMA, Hikoaki
    Niederrheinstr 18
    4000 Dusseldorf
    Germany
    Geschäftsführer
    Niederrheinstr 18
    4000 Dusseldorf
    Germany
    JapaneseDirector25960660001
    KITAOKA, Tetsuro
    3-8-44 Izumi
    FOREIGN Suginami-Ku
    Tokyo
    Japan
    Geschäftsführer
    3-8-44 Izumi
    FOREIGN Suginami-Ku
    Tokyo
    Japan
    JapaneseDirector14961940003
    KOH, Katsuo
    37-4-302 Nihonbashi Hakozakicho
    Chuo-Ku
    Tokyo
    Japan
    Geschäftsführer
    37-4-302 Nihonbashi Hakozakicho
    Chuo-Ku
    Tokyo
    Japan
    JapaneseDirector34805000001
    KOMATSU, Ichiro
    18 Imperial Court
    1 Avenue Road St Johns Wood
    NW8 9JY London
    Geschäftsführer
    18 Imperial Court
    1 Avenue Road St Johns Wood
    NW8 9JY London
    JapaneseDirector52655340001
    KOMATSU, Masakazu
    52 Ridge View Drive
    Birkby
    HD2 2EX Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    52 Ridge View Drive
    Birkby
    HD2 2EX Huddersfield
    West Yorkshire
    JapaneseGeneral Manager66606600002
    KUBO, Hirohiko
    Flat 32 Clarance Terrace
    Regents Park
    NM1 4RD London
    Geschäftsführer
    Flat 32 Clarance Terrace
    Regents Park
    NM1 4RD London
    JapaneseDirector69412540003
    KURODA, Kenso
    403 Imei Mansion 22 6 Kaki Uchi Imei
    Terato Cho Mukou Shi
    FOREIGN Kyoto
    Japan
    Geschäftsführer
    403 Imei Mansion 22 6 Kaki Uchi Imei
    Terato Cho Mukou Shi
    FOREIGN Kyoto
    Japan
    JapaneseDirector13280430002
    MAEDA, Shinichiro
    29 Park Lane
    Roundhay
    LS8 2EX Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    29 Park Lane
    Roundhay
    LS8 2EX Leeds
    West Yorkshire
    JapaneseDirector25960670002

    Hat BIRKBY'S PLASTICS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 20. Feb. 2012
    Geliefert am 21. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re: birkby's plastics limited and numbered 00552864 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 11. Sept. 2009
    Geliefert am 15. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A presma press s/no 3108/2009 together with all the mortgaged chattels. -. demag ergotech 650-3300, 650 tonne injesction moulder s/no 863-1213. toshiba IS850GT-81A 850 tonne injection moulder s/no 936612.. toshiba IS650GT 59A, 650 tonne injection moulder s/no 727801. (for further details of chattels charged please refer to form 395) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 26. Juni 2009
    Geliefert am 02. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Two dmag 1400 t moulding machines of the following specification: R21-ergotech interenational 10000-8000, machine type vd 865 0018, E20-d-1800-12900 nciii, machine no. 834 0023 with full title guarantee charges by way of first fixed and floating charge all of its rights, title and interest see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Honda of the UK Manufacturing Limited
    Transaktionen
    • 02. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 11. Jan. 2008
    Geliefert am 18. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Trustees of the Birkby's Plastics Limited Pension Scheme Being the Trustee Corporationlimited Andrew Richard Bullivant Craig Dewhirststephen Harrison Ian Hunter and Simon Kelly Together with Any Successors (Trustees)
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture
    Erstellt am 11. Jan. 2008
    Geliefert am 17. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture deed
    Erstellt am 11. Jan. 2008
    Geliefert am 17. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 11. Jan. 2008
    Geliefert am 16. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 14. Nov. 2007
    Geliefert am 26. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Engel injection moulding machine duo 11050/1700 - s/no 160172, hinge arm robot (6 axis) kuka KR150L110 s/no 160144, engine injection moulding machine duo 11050/1700 -0 s/no 165781 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 31. März 2003
    Geliefert am 07. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Imm 001 stork model: st-2500-440, 440 tonne horizontal cnc toggle type injection moulding machine with robotic unloader and related equipment, s/n 74524. imm 002 stork model: st-1600-440, 440 tonne horizontal cnc toggle type injection moulding machine with robotic unloader and related equipment, s/n 66403. imm 003 stork model: st-1600-440, 440 tonne horizontal cnc toggle type injection moulding machine with robotic unloader and related equipment, s/n 64413. for details of further chattels charged please refer to form 395, and all spare parts replacements modifications and addition and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 31. März 2003
    Geliefert am 07. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n's WYK730016, WYK318877 and WYK735540. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 31. März 2003
    Geliefert am 07. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n WYK730016. F/h land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n WYK318877. F/h land and buildings on the west side of headlands road, liversedge, heckmondwicke, west yorkshire t/n WYK735540.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estates or interests in the f/h or l/h property at headlands road liversedge west yorkshire t/n WYK730016 and WKY735540 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on such property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marubeni Corporation
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Juli 2002
    Geliefert am 04. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 25. Nov. 1997
    Geliefert am 10. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a deferment guarantee dated 11TH october 1996 in favour of h m customs & excise for £200,000
    Kurze Angaben
    The sum of £200,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 22224823 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BIRKBY'S PLASTICS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Apr. 2012Beginn der Verwaltung
    05. Apr. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    05. Apr. 2013Beginn der Liquidation
    01. Feb. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0