ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED

ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02491309
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED?

    • (4525) /
    • (7011) /

    Wo befindet sich ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FROGLAND SERVICES LIMITED10. Apr. 199010. Apr. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2009

    3 SeitenAA

    Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte

    6 SeitenSH10

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 260,900
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    11 Seiten288a

    legacy

    11 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2004

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2003

    9 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Sekretär
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish24075160004
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    FORSTER, Garry James
    Huggins Cottage
    Back Lane
    GU4 7SD East Clandon
    Surrey
    Sekretär
    Huggins Cottage
    Back Lane
    GU4 7SD East Clandon
    Surrey
    British38750850001
    NASH, Robert Leslie
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    Sekretär
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    British83397580001
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Sekretär
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010
    BARR, James Walter
    10 Broughton Crescent
    Barlaston
    ST12 9DB Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    10 Broughton Crescent
    Barlaston
    ST12 9DB Stoke On Trent
    Staffordshire
    British55617100002
    CAWDRON, James Edward
    31 Lawn Avenue
    Etwall
    DE65 6JB Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    31 Lawn Avenue
    Etwall
    DE65 6JB Derby
    Derbyshire
    British262050002
    CONNOLLY, Peter James
    147 Church Lane
    Selston
    NG16 6FB Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    147 Church Lane
    Selston
    NG16 6FB Nottingham
    Nottinghamshire
    British55292290001
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    EnglandBritish38750850004
    FOWLER, Ian Robert
    St. Enodoc
    The Green, Upper Poppleton
    YO26 6DF York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    St. Enodoc
    The Green, Upper Poppleton
    YO26 6DF York
    North Yorkshire
    British67228970001
    ORANGE, Thomas Gordon
    Foxhill Cottage
    Weetwood Lane
    LS16 5PY Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Foxhill Cottage
    Weetwood Lane
    LS16 5PY Leeds
    West Yorkshire
    British2236390001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Geschäftsführer
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Geschäftsführer
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010

    Hat ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 1995
    Geliefert am 22. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings at station plaza ilkley county of west yorkshire with all rental income & monetry debts & claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays De Zoete Wedd Limited in Its Capacity as Trustee for Itself and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental loan agreement
    Erstellt am 23. Sept. 1994
    Geliefert am 07. Okt. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The amounts referred to in an agreement dated 28TH june 1994 in accordance with the terms of the supplemental loan agreement
    Kurze Angaben
    All asset property & undertaking.
    Berechtigte Personen
    • J F Miller Properties Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 1990
    Geliefert am 20. Juli 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement and/or this debenture and/or any other security documents
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital (see form 395 ref M470C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays De Zoete Weddas Trustee for Itself & the Beneficiries
    Transaktionen
    • 20. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 29. Juni 1990
    Geliefert am 04. Juli 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 28 june 1990 and/or this charge
    Kurze Angaben
    F/H property and buildings comprising 0.739 of an acre situate at staniland way, werrington, peterborough k/as sundance house and l/h property and buildings situate at station rd, brook street and railway rd, ilkley, W. yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Thomas G Orange
    • Ian R Fowler
    • Ebs Pensioneer Trustees Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 29. Juni 1990
    Geliefert am 04. Juli 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 28 june 1990 and/or this charge
    Kurze Angaben
    F/H property and buildings comprising 0.739 of an acre situate at staniland way, werrington, peterborough k/a sundance house and l/h property and buildings situate at station rd brook street and railway rd, ilkley, w yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • J.F. Miller Properties
    Transaktionen
    • 04. Juli 1990Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0