FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED

FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02494234
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    • Gemischte Landwirtschaft (01500) / Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei

    Wo befindet sich FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mary Street House
    Mary Street
    TA1 3NW Taunton
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HORIZON KENT LIMITED08. Juli 199108. Juli 1991
    HORRELL KENT LIMITED24. Mai 199024. Mai 1990
    MARKSEAL LIMITED20. Apr. 199020. Apr. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Okt. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:resolution re: liquidators authority
    1 SeitenLIQ MISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Juni 2017

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Okt. 2016

    8 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Stonegate Holdings Ltd the Old Sidings Corsham Road Lacock Chippenham Wiltshire SN15 2LZ zum Mary Street House Mary Street Taunton TA1 3NW am 21. Juni 2017

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von James David Sheppard als Geschäftsführer am 19. Juni 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James David Sheppard als Sekretär am 19. Juni 2017

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 024942340015 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 024942340014 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 024942340013 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    8 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    7 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 024942340016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 03. Okt. 2015

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 024942340016, erstellt am 18. Apr. 2016

    35 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 024942340015, erstellt am 18. Apr. 2016

    10 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Adrian David Gott als Direktor am 18. Apr. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. März 2016

    Kapitalaufstellung am 11. März 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. Sept. 2014

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 024942340014, erstellt am 30. Mai 2015

    43 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOTT, Adrian David
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish111647120004
    COLEY, Susan Gaynor
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    Sekretär
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    British60532170001
    ELLIOTT, Julian Christopher
    3 Boconnoc Avenue
    PL17 7TN Callington
    Cornwall
    Sekretär
    3 Boconnoc Avenue
    PL17 7TN Callington
    Cornwall
    British104229500001
    KENT, Michael Richard John
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    Sekretär
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    British11373130002
    ROGERS, Nicholas Ian
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    Sekretär
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    British42807600002
    SHEPPARD, James David
    c/o Stonegate Holdings Ltd
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    Wiltshire
    England
    Sekretär
    c/o Stonegate Holdings Ltd
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    Wiltshire
    England
    147725800001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Sekretär
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    West Mills
    RG14 5HT Newbury
    Island Cottage
    Berkshire
    Sekretär
    West Mills
    RG14 5HT Newbury
    Island Cottage
    Berkshire
    British133684550001
    BALLANTYNE, Andrew Joseph, Dr
    9 Treverbyn Close
    PL14 3TG Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    9 Treverbyn Close
    PL14 3TG Liskeard
    Cornwall
    British11576400001
    COLEY, Susan Gaynor
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    British60532170001
    CORBETT, Pamela Jane
    Marston House
    Yarlet Lane, Marston
    ST18 9ST Stafford
    Geschäftsführer
    Marston House
    Yarlet Lane, Marston
    ST18 9ST Stafford
    EnglandBritish123694150001
    KENT, Joseph Edward Clifford
    Goldenbank Lodge Plymouth Road
    PL14 3PB Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Goldenbank Lodge Plymouth Road
    PL14 3PB Liskeard
    Cornwall
    British11373150001
    KENT, Michael Richard John
    The Old Rectory
    Braddock Lostwithiel
    PL22 0RN Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Braddock Lostwithiel
    PL22 0RN Liskeard
    Cornwall
    British67069980002
    KENT, Michael Richard John
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    British11373130002
    LAPTHORNE, Nigel Alan
    1 Penhale Meadow
    St Cleer
    PL14 5RR Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    1 Penhale Meadow
    St Cleer
    PL14 5RR Liskeard
    Cornwall
    British54387590001
    ROGERS, Nicholas Ian
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    British42807600003
    ROGERS, Nicholas Ian
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    British42807600002
    SHEPPARD, James David
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    United KingdomBritish123411450001
    VIGUS, Barry John
    Trevesson
    Old Road
    PL14 6DW Liskeard
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Trevesson
    Old Road
    PL14 6DW Liskeard
    Cornwall
    British69757520003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Clarence Court Eggs Limited
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    06. Apr. 2016
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer01019356
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 28. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Pamela Jane Corbett
    • Richard Gerard Heaton Corbett
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 30. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Apr. 2016
    Geliefert am 21. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2015
    Geliefert am 04. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2015
    Geliefert am 03. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Each company with full title guarantee hereby charges its credit balances to the bank to secure repayment of the secured obligations.. Please see charge document for more details.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transaktionen
    • 03. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 29. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property and all buildings and fixtures from time to time thereon known as trenouth farm st ervan wadebridge cornwall t/n CL168841.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 16. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 05. März 2008
    All assets debenture
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 05. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Feb. 2006
    Geliefert am 02. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Trenouth farm st ervan wadebridge cornwall t/n CL168841,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 05. März 2008
    • 06. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Okt. 2004
    Geliefert am 28. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2F/h property k/a trenouth farm, st ervan, wadebridge t/no. CL168841. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Aug. 2004
    Geliefert am 07. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Feb. 2001
    Geliefert am 16. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H trenouth farm st. Ervan wadebridge cornwall.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Mai 1997
    Geliefert am 21. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 1993
    Geliefert am 11. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 16. Aug. 1990
    Geliefert am 03. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company see form 395 (ref 370) for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Okt. 2018Aufgelöst am
    30. Juni 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Laurence George Russell
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset
    Praktiker
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0