EMPICS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEMPICS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02496593
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EMPICS LIMITED?

    • Fotografische Tätigkeiten n.a. (74209) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich EMPICS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EMPICS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für EMPICS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 01. Mai 2013

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Neal Simpson als Geschäftsführer am 17. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2012

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Nov. 2012

    Kapitalaufstellung am 29. Nov. 2012

    • Kapital: GBP 1,683
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010

    14 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von David Campbell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Ernennung von Steven John Brown als Sekretär

    4 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mary Cole als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009

    15 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    19 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EMPICS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWN, Steven John
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Sekretär
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    British152861810001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritish3379480001
    COLE, Mary Louise
    Parkhill Road
    Belsize Park
    NW3 2YT London
    66a
    United Kingdom
    Sekretär
    Parkhill Road
    Belsize Park
    NW3 2YT London
    66a
    United Kingdom
    British113767340002
    HODDINOTT, Caroline
    Well House 67 High Street
    Harlaxton
    NG32 1JA Grantham
    Lincolnshire
    Sekretär
    Well House 67 High Street
    Harlaxton
    NG32 1JA Grantham
    Lincolnshire
    British109447390001
    OBRIEN, Philip Paul
    Nook House 44 Brook Street
    Wymeswold
    LE12 6TU Loughborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Nook House 44 Brook Street
    Wymeswold
    LE12 6TU Loughborough
    Leicestershire
    British18266120001
    REED, Timothy
    43 Hazel Grove
    Mapperley
    NG3 6DQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    43 Hazel Grove
    Mapperley
    NG3 6DQ Nottingham
    Nottinghamshire
    British72454830001
    TEUNON, Nicholas John
    29 Monro Drive
    GU2 9PS Guildford
    Surrey
    Sekretär
    29 Monro Drive
    GU2 9PS Guildford
    Surrey
    British80035420001
    BUCKLEY, Christopher
    Church House
    Gate Helmsley
    YO41 1JS York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Church House
    Gate Helmsley
    YO41 1JS York
    Yorkshire
    United KingdomBritish54211650003
    CAMPBELL, David Ian
    85 The Village
    Haxby
    YO32 2JE York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    85 The Village
    Haxby
    YO32 2JE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish104602970001
    CHILCOTT, Martin Nicholas
    10 Belbroughton Road
    OX2 6UZ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    10 Belbroughton Road
    OX2 6UZ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish82059240001
    CROSS, Graham
    41 Folkestone Road
    E17 9SD London
    Geschäftsführer
    41 Folkestone Road
    E17 9SD London
    British67771870001
    ETHERINGTON, Stephen Nicholas
    31 Lime Grove
    Bottesford
    NG13 0BH Nottingham
    N0ttinghamshire
    Geschäftsführer
    31 Lime Grove
    Bottesford
    NG13 0BH Nottingham
    N0ttinghamshire
    EnglandBritish121166640001
    HODDINOTT, Caroline
    Well House 67 High Street
    Harlaxton
    NG32 1JA Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Well House 67 High Street
    Harlaxton
    NG32 1JA Grantham
    Lincolnshire
    British109447390001
    JARDINE, Margaret Muir
    7 Wychwood Road
    Bingham
    NG13 8SX Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    7 Wychwood Road
    Bingham
    NG13 8SX Nottingham
    Nottinghamshire
    British13634310001
    KINNAIRD, Ross Andrew
    161 Endeaby Road
    LE8 Whetstone
    Leics
    Geschäftsführer
    161 Endeaby Road
    LE8 Whetstone
    Leics
    British18266130001
    MCGARRICK, Andrew Charles
    24 High Street
    NN17 3DE Gretton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    24 High Street
    NN17 3DE Gretton
    Northamptonshire
    EnglandBritish79518090001
    OBRIEN, Philip Paul
    Well House 67 High Street
    Harlaxton
    NG32 1JA Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Well House 67 High Street
    Harlaxton
    NG32 1JA Grantham
    Lincolnshire
    British18266120002
    SHAW, Richard
    25 Loddon Close
    OX14 3TB Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    25 Loddon Close
    OX14 3TB Abingdon
    Oxfordshire
    British44783950001
    SIMPSON, Neal
    Bumble Bee Cottage
    Highfield
    ST13 8SG Leek
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bumble Bee Cottage
    Highfield
    ST13 8SG Leek
    Staffordshire
    British63586140001
    SIMPSON, Robert Brian
    1 Combe Royal Crescent
    BA2 6EZ Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    1 Combe Royal Crescent
    BA2 6EZ Bath
    Avon
    British100368690001
    TEUNON, Nicholas John
    Ridge House
    11 Groveside, Bookham
    KT23 4LD Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Ridge House
    11 Groveside, Bookham
    KT23 4LD Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish190358900001

    Hat EMPICS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Okt. 2008
    Geliefert am 29. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 27. Okt. 2008
    Geliefert am 29. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2006
    Geliefert am 18. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Okt. 2003
    Geliefert am 10. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2001
    Geliefert am 25. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. Apr. 2000
    Geliefert am 21. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £30,078.12 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    An underlease dated 5TH april 2000 in respect of land and buildings k/a the pavilion castle boulevard nottingham.
    Berechtigte Personen
    • Games Workshop Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 15. Feb. 1999
    Geliefert am 27. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sums owing by the company to the chargee pursuant to a deed of sale dated 29TH january 1999
    Kurze Angaben
    All photographs taken by mr peter robinson at any time prior to 29TH january 1999 of or relating to the sport of football,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Peter Robinson
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First fixed charge & floating charge
    Erstellt am 05. Feb. 1999
    Geliefert am 09. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge on all our book debts and other debts present and future as are not sold to and bought by the chargee under an agreement dated 5TH february 1999 and by way of floating charge all proceeds of book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transaktionen
    • 09. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 02. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 30. März 1994
    Geliefert am 31. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 14. Juni 1990
    Geliefert am 21. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge own the undertaking and all propety and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 11. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EMPICS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Apr. 2014Aufgelöst am
    01. Mai 2013Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0