HOZELOCK GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HOZELOCK GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02496708 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOZELOCK GROUP LIMITED?
- Herstellung von anderen Kunststoffwaren (22290) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FLYVILLE LIMITED | 27. Apr. 1990 | 27. Apr. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Yves Emile Pierre Belegaud als Direktor am 17. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Guerric Ballu as a person with significant control on 17. Dez. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Guerric Ballu als Geschäftsführer am 17. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Emmanuel Julien Perrousset als Sekretär am 30. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Thorington Jones als Sekretär am 30. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Gary Thorington Jones als Sekretär am 24. März 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Semmens als Sekretär am 23. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2016 bis 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Helen Semmens als Sekretär am 01. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERROUSSET, Emmanuel Julien | Sekretär | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 240709370001 | |||||||
| BALLU, Marc | Geschäftsführer | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | United Kingdom | French | 174120160002 | |||||
| BELEGAUD, Yves Emile Pierre | Geschäftsführer | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | France | French | 265689980001 | |||||
| JONES, Gary Thorington | Sekretär | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 207074230001 | |||||||
| POTTER, Donald Stanley | Sekretär | Crispins 64 The Avenue Worminghall HP18 9LE Aylesbury Buckinghamshire | British | 14077190001 | ||||||
| SEMMENS, Helen | Sekretär | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 199904670001 | |||||||
| WOOD, Martin | Sekretär | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | 153428180001 | |||||||
| ADAMS, Peter George | Geschäftsführer | Lower Northcott Farm Sheldon EX15 2JF Cullompton Devon | British | 112143030001 | ||||||
| ALGAR, David Stanley | Geschäftsführer | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | England | British | 104137450004 | |||||
| BALLU, Guerric | Geschäftsführer | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | France | French | 80574650002 | |||||
| CODLING, David Fletcher | Geschäftsführer | Bowers Farm Magpie Lane HP7 0LU Coleshill Amersham Buckinghamshire | British | 14064770002 | ||||||
| DUDEK, Michael Henry | Geschäftsführer | Walnut Tree Cottage Walton Lane Wellesbourne CV35 9RD Warwickshire | British | 39236340002 | ||||||
| FEWELL, Peter William Charles | Geschäftsführer | Mount Pleasant Farm Thame Road OX44 7HX Great Milton Oxon | British | 14037250003 | ||||||
| FLEURAT, Pierre | Geschäftsführer | 9 Avenue Elisee Reclus FOREIGN 75007 Paris France | French | 72217940002 | ||||||
| FOBEL, Anthony Peter | Geschäftsführer | 1st Floor Flat 105 King Henrys Road NW3 3QX London | British | 71917500001 | ||||||
| HALL, Stephen John | Geschäftsführer | Adringal Cottages Horton Horton Hill BS37 6QP Bristol 1 | England | British | 147526740001 | |||||
| HARGREAVES, David | Geschäftsführer | Willards Farm The Common Dunsfold GU8 4LB Godalming Surrey | British | 54809160001 | ||||||
| HART, Raymond John | Geschäftsführer | Witches Broom Raggleswood BR7 5NH Chislehurst Kent | British | 63042500002 | ||||||
| MACKENZIE, Alexander Donald | Geschäftsführer | Shalden Lodge Shalden Lane Shalden GU34 4DU Alton Hampshire | United Kingdom | British | 105120270001 | |||||
| MASKELL, Philip John | Geschäftsführer | 1 Grange Cottages Broad Common Road RG10 0RD Hurst Berkshire | British | 5733160002 | ||||||
| POTTER, Donald Stanley | Geschäftsführer | Crispins 64 The Avenue Worminghall HP18 9LE Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 14077190001 | |||||
| ROLLAND, Stuart Stacy | Geschäftsführer | Rosemary Cottage Northchurch HP4 3QS Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 206839450001 | |||||
| RUSH, Peter John | Geschäftsführer | 2 The Conifers Birches Lane CV8 2BF Kenilworth Warwickshire | England | British | 94039640002 | |||||
| SNOWDEN, Paul Boothby | Geschäftsführer | 10 Dunton Close Four Oaks B75 5QD Sutton Coldfield Birmingham | British | 69874210002 | ||||||
| WALKER, Gerald Neill | Geschäftsführer | The Laurels 5 Aston Gardens Aston Rowant OX49 5SY Watlington Oxfordshire | British | 84568760001 | ||||||
| WOOD, Martin Richard | Geschäftsführer | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | England | British | 152495780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HOZELOCK GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Guerric Ballu | 06. Apr. 2016 | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | Ja |
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: France | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Marc Ballu | 06. Apr. 2016 | Midpoint Park Minworth B76 1AB Sutton Coldfield | Nein |
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat HOZELOCK GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 15. März 2010 Geliefert am 24. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 16. Jan. 2009 Geliefert am 17. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 29. Juli 1999 Geliefert am 12. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture and guarantee | Erstellt am 30. Juni 1993 Geliefert am 07. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 25TH april 1990 (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture & guarantee. | Erstellt am 17. Juli 1990 Geliefert am 06. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein on the chargee under the terms of the facilities agreement dated 17/7/90 and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0