BOYTON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BOYTON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02501390 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BOYTON LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich BOYTON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor Parkgates Bury New Road M25 0TL Prestwich Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BOYTON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BOYTON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 25. März 2017 bis 24. März 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of Boyton Holdings Ltd as a person with significant control on 05. Mai 2017 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Susane Lebrecht als Direktor am 05. Mai 2017 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Bernard Janus Lebrecht als Direktor am 05. Mai 2017 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Berkeley als Geschäftsführer am 05. Mai 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Marks als Geschäftsführer am 05. Mai 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vanessa Shane Marks als Sekretär am 05. Mai 2017 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 26. März 2016 bis 25. März 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 27. März 2014 bis 26. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BOYTON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBRECHT, Bernard Janus | Geschäftsführer | Tully Street M7 2BB Salford 23 England | United Kingdom | English | 142802040001 | |||||
| LEBRECHT, Susane | Geschäftsführer | Tully Street M7 2BB Salford 23 England | England | British | 8278980003 | |||||
| MARKS, Jonathan | Sekretär | 33 Singleton Road M7 4NN Salford Lancashire | British | 22120950001 | ||||||
| MARKS, Vanessa Shane | Sekretär | Rechov Graetz Jerusalem 93111 Apt 12/2 Israel | Israeli | 42593440001 | ||||||
| BERKELEY, Andrew | Geschäftsführer | Bury New Road Prestwich M25 0TL Manchester 2nd Floor - Parkgates United Kingdom | United Kingdom | British | 180346700002 | |||||
| HAMMELBURGER, Michael | Geschäftsführer | 30 Shderot Ben Maimon Jerusalem 92261 Dira 5 Israel | Israel | British | 22120960003 | |||||
| MARKS, Jonathan | Geschäftsführer | Rechov Graetz Jerusalem 93111 Apt 12/2 Israel | Israel | British | 142381920005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BOYTON LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyton Holdings Ltd | 05. Mai 2017 | Bury New Road M25 0TL Prestwich 2nd Floor Parkgates England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat BOYTON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 15. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tilson estates limited and tilson estates 2 limited to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 6A stone cross park east lancashire road golborne wigan greater manchester. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 15. Jan. 2001 Geliefert am 17. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the liabilities of deeside estates limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings being unit 107 deeside industrial park deeside - WA850486. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Nov. 1998 Geliefert am 26. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from wellingford property limited (the nominee) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 15 millbrook ind est rotherfield road jarvis brook crowborough wealden east sussex t/no ESX41288. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Mai 1997 Geliefert am 24. Mai 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property 6 cleethorpes road great grimsby humberside t/no HS170726 by way of. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 19. Juli 1996 Geliefert am 23. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the liabilities and obligations of queen street management services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 45/45A ipswich street stowmarket suffolk and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 19. Juli 1996 Geliefert am 23. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the liabilities and obligations now due or to become due from queen street management services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 23/23A king street and 54A deneside great yarmouth together with. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Okt. 1995 Geliefert am 10. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from westerfield limited to the chargee | |
Kurze Angaben Legal mortgage over land and buildings to south of great hanover street and to north of essex street and to north of essex street preston lancashire title number LA206005. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses from time to time carried on by or for the account of the company. Floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work-in-progress and other chatells. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 29. Sept. 1995 Geliefert am 06. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ridelake limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property- excalibur buildings whitworth st,manchester,gt.manchester; t/no.gm 470474 with all fixed plant/machinery,fixtures/fittings thereon; the goodwill of business and all furniture,furnishings,equipment tools and other chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Aug. 1995 Geliefert am 17. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property k/as unit b (parts a & b) loverock road,battle farm industrial estate,reading berkshire.t/no.BK270574.specific charge the goodwill and connection of the business or businesses from time to time carried on by or for the account of the company upon the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 02. Juni 1995 Geliefert am 13. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from shawhead limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the mortgagor's interest (if any) in the l/h property k/a city hall beaumont fee lincoln lincolnshire the present of future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Dez. 1990 Geliefert am 31. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee including further advances (if any) | |
Kurze Angaben Units 1 and 2 kennedy way, stockport (greater manchester). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1990 Geliefert am 14. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the east side of green lane stockport, greater manchester t/no ch 82829 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0