SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02501443 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Eboracum Way Heworth Green YO31 7RE York Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ARTFRESH LIMITED | 11. Mai 1990 | 11. Mai 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von John Daniel Mclaughlin als Geschäftsführer am 02. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Hugo Charles Kimber als Geschäftsführer am 02. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Abhishek Goenka als Geschäftsführer am 10. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan David Ross als Geschäftsführer am 23. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 46 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Eintragung der Belastung 025014430010, erstellt am 29. Nov. 2018 | 32 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 025014430011, erstellt am 29. Nov. 2018 | 50 Seiten | MR01 | ||
Erfüllung der Belastung 025014430009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jacqueline Susan Rigby als Geschäftsführer am 11. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 48 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Beendigung der Bestellung von Alistair Rodger als Geschäftsführer am 31. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr. John Daniel Mclaughlin als Direktor am 03. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr. Jonathan David Ross als Direktor am 03. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Ms. Jacqueline Susan Rigby als Direktor am 03. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERKAR, Ajay Ajit Peter | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | Indian | Company Director | 171005990001 | ||||
BADDELEY, Robert Gregory | Sekretär | 2 Devisdale Grange Groby Road Bowdon WA14 2BY Altrincham Cheshire | British | Company Director | 28024220004 | |||||
CULLEN, Dominique | Sekretär | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | 195246320001 | |||||||
MAY, Timothy William | Sekretär | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | 192246940001 | |||||||
WILLIAMSON, Alexandra Dilys | Sekretär | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | British | 100325220002 | ||||||
WRAY, Mark Christopher | Sekretär | 32 Hillcrest Avenue Nether Poppleton YO2 6LD York | British | 25762230002 | ||||||
ALLAN, Leslie Stewart | Geschäftsführer | 78 Honor Oak Road SE23 3RR London | British | Merchant Banker | 1704690001 | |||||
ATKINS, Jane Louise | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | Sales Director | 207125210001 | ||||
ATKINSON, Richard Westaway | Geschäftsführer | Smithy Lane Farm Rainow SK10 5UP Macclesfield Cheshire | England | British | Director | 111861370001 | ||||
BADDELEY, Robert Gregory | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | Great Britain | British | Company Director | 28024220020 | ||||
BALI, Navneet | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 83088120002 | ||||
BRIGHT, Neil Irvine | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 180993450001 | ||||
CREW, James Robert | Geschäftsführer | 123 Hale Road Hale WA15 9HQ Altrincham Cheshire | British | Director | 15842470001 | |||||
CUST, Nicholas Pury | Geschäftsführer | Crookhill The Village Skelton YO3 6XY York | United Kingdom | British | Company Director | 159977730001 | ||||
DAVIES, Martin William Oliver | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 98399000002 | ||||
FENNEMORE, Roger Arnold | Geschäftsführer | 25 Chapel Street Woburn Sands MK17 8PG Milton Keynes Buckinghamshire | British | Company Director | 9399600002 | |||||
FERRIN, Eamonn | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire | United Kingdom | Irish | Company Director | 146776900001 | ||||
GOENKA, Abhishek | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | Indian | General Manager | 192234860001 | ||||
HOPE, Stuart Malcolm Ronald | Geschäftsführer | 8 Nesbitt Square Coxwell Road SE19 3AB London | British | Company Director | 49358260001 | |||||
JARVIS, Susan | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 199100680002 | ||||
JONES, Raymond Anthony Patrick | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 60728450002 | ||||
KIMBER, Hugo Charles | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | England | British | Executive Chairman | 113847000002 | ||||
LEPPARD, Martin Neal | Geschäftsführer | Claverdon Manor Manor Lane CV35 8NH Claverdon Warwickshire | England | British | Company Director | 155863600001 | ||||
MAY, Timothy William | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | England | British | Treasurer | 27408660003 | ||||
MCLAUGHLIN, John Daniel | Geschäftsführer | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd England | United Kingdom | British | Group Finance Head | 230948990001 | ||||
MICHEL, Carl Heinrich | Geschäftsführer | 2 College Place Hortensia Road SW10 0QZ London | England | British | Director | 107791560001 | ||||
MOUNSER, Ian Peter | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tour Operator | 50419570001 | ||||
NEYLON, Darren Lee | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | England | English | Company Director | 69978820001 | ||||
REGAN, Frank | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tour Operator | 35768770001 | ||||
RIGBY, Jacqueline Susan, Dr | Geschäftsführer | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd England | England | British | Chief Operating Officer | 230918770001 | ||||
RODGER, Alistair | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 246630430001 | ||||
ROSS, Jonathan David | Geschäftsführer | Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Ltd England | England | British | Chief Technology Officer | 48869790001 | ||||
WADHAMS, Tim | Geschäftsführer | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Technology Officer | 206620140001 | ||||
WILLIAMSON, Alexandra Dilys | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 100325220002 | ||||
WRAY, Mark Christopher | Geschäftsführer | The Granary Church Lane Nether Poppleton YO26 6LF York | United Kingdom | British | Company Director | 25762230003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malvern Travel Limited | 06. Apr. 2016 | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SUPERBREAK MINI HOLIDAYS GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2018 Geliefert am 05. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2018 Geliefert am 05. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung N/A. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 11. Mai 2016 Geliefert am 17. Mai 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung A fixed charge over the intellectual property right in respect of the trademark with trademark number 3289501 and other intellectual property rights detailed in part 4 of schedule 1 to the charging instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 04. Sept. 2014 Geliefert am 15. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
English law security agreement | Erstellt am 29. Juni 2012 Geliefert am 13. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 09. Mai 2008 Geliefert am 16. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Hartford manor hartford northwich t/no CH424893. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Aug. 2000 Geliefert am 16. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to the debenture dated 3RD february 1995 | Erstellt am 09. Feb. 1998 Geliefert am 11. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities at the date of the supplemental deed or thereafter due owing or incurred by the company to national westminster bank PLC (the "security trustee") and to the beneficiaries (as defined) or any of them (whether under the facility agreements,and the facility documents as defined or otherwise) and by guarantee the obligations of each other company and any other subsidiary of the parent (the guaranteed obligations) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Juli 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether under any of the facility agreements, the facility documents (as defined therein) or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juni 1990 Geliefert am 29. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompanys and/or superbreak mini holidayslimited under the terms of the charge to the chargee. | |
Kurze Angaben (See doc M247 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 14. Juni 1990 Geliefert am 29. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany to the chargee under or by virtue of the indemnity and/or clause 17.4 of a facilities agreement dated 14/06/90 | |
Kurze Angaben All the companys right, title and interest in and to all moneys the collateral in whatever. Currency at the date of the security agreement or atany time standing to the credit of the. Account designated barclays bank PLC re artfresh limited with barclays bank finance company. Jersey limited see doc M249 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0