MNE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MNE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02503995 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MNE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MNE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Croft Road Crossflatts BD16 2UA Bingley West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MNE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DESIGNJOB LIMITED | 21. Mai 1990 | 21. Mai 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MNE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MNE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MNE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Gornall als Sekretär am 30. Juni 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Martin Hopkinson als Geschäftsführer am 30. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Claire Louise Craigie als Sekretär am 30. Juni 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Gornall als Direktor am 30. Juni 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Ian John Hares als Direktor am 25. Nov. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Phillip Alexander Mclelland als Geschäftsführer am 25. Nov. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 31. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Gornall als Sekretär am 03. Dez. 2012 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MNE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAIGIE, Claire Louise | Sekretär | Croft Road, Crossflatts BD16 2UA Bingley Uk Asset Resolution Limited West Yorkshire England | 190359110001 | |||||||
| GORNALL, John | Geschäftsführer | Croft Road, Crossflatts BD16 2UA Bingley Bradford & Bingley Plc West Yorkshire England | England | British | 41289370001 | |||||
| HARES, Ian John | Geschäftsführer | Croft Road Crossflatts BD16 2UA Bingley Ukar West Yorkshire | United Kingdom | British | 55792230001 | |||||
| BASEY, Kevin Michael | Sekretär | The Old School NE46 4LN Anick Northumberland | British | 40906890001 | ||||||
| FORSTER, Ian | Sekretär | 26 Croftside Etherley Park DL14 0ST Bishop Auckland County Durham | British | 37511580001 | ||||||
| GORNALL, John | Sekretär | Crossflatts BD16 2UA Bingley Croft Road West Yorkshire | 174534770001 | |||||||
| GREENER, Colin Tom | Sekretär | Glebe Croft 4 Delhi View Ryton NE40 4QR Gateshead Tyne & Wear | British | 74462200001 | ||||||
| HODGSON, David John | Sekretär | 183 Queen Alexandra Road SR3 1XN Sunderland Tyne & Wear | British | 1421500001 | ||||||
| HODGSON, David John | Sekretär | 183 Queen Alexandra Road SR3 1XN Sunderland Tyne & Wear | British | 1421500001 | ||||||
| MCBURNIE, Alan | Sekretär | 11 The Court Whickham NE16 4HW Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 65832330001 | ||||||
| SCOTT, Thomas Gordon | Sekretär | 23 Belsay Avenue NE25 8PY Whitley Bay Tyne & Wear | British | 39809260001 | ||||||
| SHIPLEY, Julie | Sekretär | Crossflatts BD16 2UA Bingley Croft Road West Yorkshire | British | 155609980001 | ||||||
| WILLIAMS, Gwilym Caisley | Sekretär | 18 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | 112895630002 | ||||||
| WILLIAMS, Gwilym Caisley | Sekretär | 18 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | 112895630002 | ||||||
| BASEY, Kevin Michael | Geschäftsführer | The Old School NE46 4LN Anick Northumberland | British | 40906890001 | ||||||
| BLAKEY, Colin | Geschäftsführer | 133 Eastern Way Darras Hall NE20 9RH Ponteland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 18947160001 | |||||
| CROFT, Michael | Geschäftsführer | 14 Whithorn Court NE24 5JB Blyth Northumberland | British | 78418730001 | ||||||
| DHIRANI, Sharandeep Kaur | Geschäftsführer | 107 Western Way Darras Hall NE20 9LY Ponteland Northumberland | England | British | 125654700001 | |||||
| FORSTER, Ian | Geschäftsführer | 26 Croftside Etherley Park DL14 0ST Bishop Auckland County Durham | British | 37511580001 | ||||||
| FREEMAN, Clive Gregory | Geschäftsführer | 63 Dene Lane Fulwell SR6 8EH Sunderland Tyne And Wear | British | 40906940001 | ||||||
| GOULDING, Gerald Peter | Geschäftsführer | 8 Ewesley Rickleton NE38 9JG Washington Tyne & Wear | British | 4679250001 | ||||||
| GREENER, Colin Tom | Geschäftsführer | Glebe Croft 4 Delhi View Ryton NE40 4QR Gateshead Tyne & Wear | England | British | 74462200001 | |||||
| GRIFFIN, Angus Macdonald | Geschäftsführer | 8a West Park Road Cleadon SR6 7RR Sunderland Tyne & Wear | British | 43223950001 | ||||||
| HOPKINSON, Paul Martin | Geschäftsführer | Croft Road Crossflatts BD16 2UA Bingley Bradford & Bingley Plc West Yorkshire England | Great Britain | British | 61412160002 | |||||
| LINDEN, Robert Wallace | Geschäftsführer | Ardmair 6 Lowes Fall The Downs DH1 4NP Durham | British | 1421490003 | ||||||
| MCLELLAND, Phillip Alexander | Geschäftsführer | Croft Road Crossflatts BD16 2UA Bingley Bradford & Bingley Plc West Yorkshire England | United Kingdom | British | 138782370001 | |||||
| MUIRHEAD, Peter | Geschäftsführer | 4 Gladstone Terrace Sandyford NE2 1AY Newcastle Upon Tyne | British | 36273740001 |
Hat MNE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2009 Geliefert am 15. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property at gosforth newcastle upon tyne (TY480821) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 2008 Geliefert am 10. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Dez. 2007 Geliefert am 12. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge over all right title and interest in and to the real property with all buildings fixtures fittings plant and machinery thereon; any goodwill of business and other rights,the investments,intellectual property,shares,dividends and other monies payable; all monetary claims and related rights,proceeds of any insurance,specific contracts,etc.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 13. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10 olney close cramlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 13. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 7 lily avenue bedlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 13. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 29 northolt avenue cramlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 13. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 14 westmount killingworth tyne and wear tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Sept. 1992 Geliefert am 07. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,180,698.00 | |
Kurze Angaben 5.048 acres of land at cowpen road blyth northumberland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. März 1992 Geliefert am 03. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £555,124.00 including further advances | |
Kurze Angaben 1.46 acres of land at iolanthe terrace south shields tyne and wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 30. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £938,105.00 | |
Kurze Angaben 2.035 acres of land at denecroft wylam northumberland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. März 1991 Geliefert am 05. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,754,830-00 and further advances due or to become due form the company to the chargee. | |
Kurze Angaben Seven acres of land at east bailey, killingworth, tyne & wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 26. Juli 1990 Geliefert am 11. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0