MNE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMNE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02503995
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MNE LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich MNE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MNE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DESIGNJOB LIMITED21. Mai 199021. Mai 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MNE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MNE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MNE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von John Gornall als Sekretär am 30. Juni 2014

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Martin Hopkinson als Geschäftsführer am 30. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Claire Louise Craigie als Sekretär am 30. Juni 2014

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr John Gornall als Direktor am 30. Juni 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Juni 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Ernennung von Mr Ian John Hares als Direktor am 25. Nov. 2013

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Phillip Alexander Mclelland als Geschäftsführer am 25. Nov. 2013

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    18 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 31. März 2014

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mr John Gornall als Sekretär am 03. Dez. 2012

    1 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von MNE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CRAIGIE, Claire Louise
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Uk Asset Resolution Limited
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Uk Asset Resolution Limited
    West Yorkshire
    England
    190359110001
    GORNALL, John
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish41289370001
    HARES, Ian John
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Ukar
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Ukar
    West Yorkshire
    United KingdomBritish55792230001
    BASEY, Kevin Michael
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    Sekretär
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    British40906890001
    FORSTER, Ian
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    British37511580001
    GORNALL, John
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    Sekretär
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    174534770001
    GREENER, Colin Tom
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    British74462200001
    HODGSON, David John
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    British1421500001
    HODGSON, David John
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    British1421500001
    MCBURNIE, Alan
    11 The Court
    Whickham
    NE16 4HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    11 The Court
    Whickham
    NE16 4HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65832330001
    SCOTT, Thomas Gordon
    23 Belsay Avenue
    NE25 8PY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    23 Belsay Avenue
    NE25 8PY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British39809260001
    SHIPLEY, Julie
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    Sekretär
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    British155609980001
    WILLIAMS, Gwilym Caisley
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British112895630002
    WILLIAMS, Gwilym Caisley
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British112895630002
    BASEY, Kevin Michael
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    British40906890001
    BLAKEY, Colin
    133 Eastern Way
    Darras Hall
    NE20 9RH Ponteland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    133 Eastern Way
    Darras Hall
    NE20 9RH Ponteland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish18947160001
    CROFT, Michael
    14 Whithorn Court
    NE24 5JB Blyth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    14 Whithorn Court
    NE24 5JB Blyth
    Northumberland
    British78418730001
    DHIRANI, Sharandeep Kaur
    107 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Ponteland
    Northumberland
    Geschäftsführer
    107 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Ponteland
    Northumberland
    EnglandBritish125654700001
    FORSTER, Ian
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    British37511580001
    FREEMAN, Clive Gregory
    63 Dene Lane
    Fulwell
    SR6 8EH Sunderland
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    63 Dene Lane
    Fulwell
    SR6 8EH Sunderland
    Tyne And Wear
    British40906940001
    GOULDING, Gerald Peter
    8 Ewesley
    Rickleton
    NE38 9JG Washington
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    8 Ewesley
    Rickleton
    NE38 9JG Washington
    Tyne & Wear
    British4679250001
    GREENER, Colin Tom
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritish74462200001
    GRIFFIN, Angus Macdonald
    8a West Park Road
    Cleadon
    SR6 7RR Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    8a West Park Road
    Cleadon
    SR6 7RR Sunderland
    Tyne & Wear
    British43223950001
    HOPKINSON, Paul Martin
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Great BritainBritish61412160002
    LINDEN, Robert Wallace
    Ardmair
    6 Lowes Fall The Downs
    DH1 4NP Durham
    Geschäftsführer
    Ardmair
    6 Lowes Fall The Downs
    DH1 4NP Durham
    British1421490003
    MCLELLAND, Phillip Alexander
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish138782370001
    MUIRHEAD, Peter
    4 Gladstone Terrace
    Sandyford
    NE2 1AY Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    4 Gladstone Terrace
    Sandyford
    NE2 1AY Newcastle Upon Tyne
    British36273740001

    Hat MNE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 2009
    Geliefert am 15. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property at gosforth newcastle upon tyne (TY480821) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Aug. 2008
    Geliefert am 10. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England as Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Dez. 2007
    Geliefert am 12. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all right title and interest in and to the real property with all buildings fixtures fittings plant and machinery thereon; any goodwill of business and other rights,the investments,intellectual property,shares,dividends and other monies payable; all monetary claims and related rights,proceeds of any insurance,specific contracts,etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 olney close cramlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7 lily avenue bedlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 northolt avenue cramlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 westmount killingworth tyne and wear tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 04. Sept. 1992
    Geliefert am 07. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,180,698.00
    Kurze Angaben
    5.048 acres of land at cowpen road blyth northumberland.
    Berechtigte Personen
    • North of England Building Society
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 31. März 1992
    Geliefert am 03. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £555,124.00 including further advances
    Kurze Angaben
    1.46 acres of land at iolanthe terrace south shields tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • The North of England Building Society
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Jan. 1992
    Geliefert am 30. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £938,105.00
    Kurze Angaben
    2.035 acres of land at denecroft wylam northumberland.
    Berechtigte Personen
    • North of England Building Society
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 05. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,754,830-00 and further advances due or to become due form the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    Seven acres of land at east bailey, killingworth, tyne & wear.
    Berechtigte Personen
    • North of England Building Society.
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 30. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 26. Juli 1990
    Geliefert am 11. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • North of England Building Society
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0