NSIP (ETS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NSIP (ETS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02504173 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NSIP (ETS) LIMITED?
- Erbringung von Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasgewinnung (09100) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Wo befindet sich NSIP (ETS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NSIP (ETS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CH4 PIPELINES LIMITED | 28. Juli 2003 | 28. Juli 2003 |
| CALENERGY GAS (PIPELINES) LIMITED | 08. Dez. 1997 | 08. Dez. 1997 |
| POWER TOWER LIMITED | 06. Juli 1990 | 06. Juli 1990 |
| HASTESPOT LIMITED | 21. Mai 1990 | 21. Mai 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NSIP (ETS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NSIP (ETS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Jack Robert Luypaert am 08. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Jack Robert Luypaert am 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Kellas North Sea 2 Limited as a person with significant control on 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew David Hessell am 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Guy Robert Maurice Appleton am 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 14 st. George Street London W1S 1FE United Kingdom zum Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB am 04. Feb. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr Thomas Jack Robert Luypaert als Direktor am 30. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Guillaume Jacques Robert Friedel als Geschäftsführer am 30. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephane Julien Ifker als Geschäftsführer am 30. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark John Crosbie als Geschäftsführer am 30. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Guillaume Jacques Robert Friedel am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Antin North Sea 2 Limited as a person with significant control on 16. Sept. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 24 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 025041730011 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Mr Mark John Crosbie zum Geschäftsführer | 6 Seiten | RP04AP01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Guillaume Jacques Robert Friedel am 20. Juni 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 25 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 14 st George Street London London W1S 1FE zum 14 st. George Street London W1S 1FE am 05. Juli 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Antin North Sea 2 Limited as a person with significant control on 15. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NSIP (ETS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLETON, Guy Robert Maurice | Geschäftsführer | 7th Floor, The Silver Fin Building 455 Union Street AB11 6DB Aberdeen Kellas Midstream Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 156848840001 | |||||||||
| HESSELL, Andrew David | Geschäftsführer | 7th Floor, The Silver Fin Building 455 Union Street AB11 6DB Aberdeen Kellas Midstream Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 221140270001 | |||||||||
| LUYPAERT, Thomas Jack Robert | Geschäftsführer | Throgmorton Avenue EC2N 2DL London 12 United Kingdom | United Kingdom | French | 264133230002 | |||||||||
| GILES, Gail Valerie | Sekretär | North Sundaysight Bellingham NE48 2JE Hexham Northumberland | British | 108926390001 | ||||||||||
| HOBDEN, Brian | Sekretär | 40 Woodburn Crescent AB15 8JX Aberdeen | British | 81368370001 | ||||||||||
| KIRK, Philip Andrew | Sekretär | 5 Old Deer Park Gardens TW9 2TN Richmond Surrey | British | 84103730001 | ||||||||||
| MISTRY, Bhavna | Sekretär | 37 Warren Road Whitton TW2 7DH Twickenham Middlesex | British | 87625170001 | ||||||||||
| SPARKES, Michael Jack | Sekretär | The Pantiles Main Street Thorney NG23 7BS Newark Nottinghamshire | British | 43902400001 | ||||||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Sekretär | 2 Chestnut Lane AB31 5PH Banchory Aberdeenshire | British | 117008750002 | ||||||||||
| CENTRICA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire |
| 146095800001 | ||||||||||
| WEIL, GOTSHAL & MANGES (LONDON) LLP | Sekretär | Fetter Lane EC4A 1AY London 110 United Kingdom |
| 199087250001 | ||||||||||
| ABEL, Gregory Edward | Geschäftsführer | 4710 George Mills Parkway 402 50265 West Des Moines Iowa United States | Usa | Canadian | 52806480009 | |||||||||
| BEGBIE, Roderick Mcintosh | Geschäftsführer | 11 Kepplestone Gardens AB15 4DH Aberdeen Aberdeenshire | British | 115205850001 | ||||||||||
| BRICKNELL, Bruce David Neil | Geschäftsführer | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 184345640001 | |||||||||
| CLAYTON, Marie-Louise | Geschäftsführer | 309 North Deeside Road AB13 0DL Aberdeen | British | 103782580001 | ||||||||||
| CONNOR, Phillip Eric | Geschäftsführer | Billy Hill House Stanley DL15 9QS Crook County Durham | England | English | 72946860001 | |||||||||
| CROSBIE, Mark John | Geschäftsführer | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | United Kingdom | British | 211079810001 | |||||||||
| DAVIES, John George | Geschäftsführer | Cotchet Barn Blackdown GU27 3BS Haslemere Surrey | British | 54724650001 | ||||||||||
| DIXON, Ronald | Geschäftsführer | 1 Berkley Avenue NE21 5NN Blaydon Tyne & Wear | England | British | 2318270001 | |||||||||
| FRIEDEL, Guillaume Jacques Robert | Geschäftsführer | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | United States | French | 189459340023 | |||||||||
| GILES, Gail Valerie | Geschäftsführer | North Sundaysight Bellingham NE48 2JE Hexham Northumberland | England | British | 108926390001 | |||||||||
| GROVES, Alan | Geschäftsführer | 37 Avondale Road Ponteland NE20 9NA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 2318230001 | ||||||||||
| GUGEN, Francis Robert | Geschäftsführer | Down Street W1J 7AJ London 7 | United Kingdom | British | 388450006 | |||||||||
| HANAFIN, Vincent Mark | Geschäftsführer | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | United Kingdom | British | 131999620002 | |||||||||
| IFKER, Stephane Julien | Geschäftsführer | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | France | French | 229631470001 | |||||||||
| KIRK, Philip Andrew | Geschäftsführer | 5 Old Deer Park Gardens TW9 2TN Richmond Surrey | British | 84103730001 | ||||||||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Geschäftsführer | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | England | British | 4958800007 | |||||||||
| LINGE, Kenneth | Geschäftsführer | Drystones Heugh House Lane NE47 6ND Haydon Bridge Northumberland | England | British | 52698930001 | |||||||||
| LUMSDEN, Roy Andrew | Geschäftsführer | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | United Kingdom | British | 199053700001 | |||||||||
| MORRIS, David Richard | Geschäftsführer | Churchfield 1 Top Street Wing LE15 8SE Oakham Leicestershire | United Kingdom | British | 36692700001 | |||||||||
| MURPHY, Jonathan David | Geschäftsführer | 74 Beaconsfield Place AB15 4AJ Aberdeen Aberdeenshire | British | 115205970001 | ||||||||||
| OZSANLAV, Richard | Geschäftsführer | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147826530002 | |||||||||
| PICOTTE, Christopher | Geschäftsführer | 200 Clarendon Street 55th Floor MA 02117 Boston Arclight Capital Partners Llc Usa | American | 116230600001 | ||||||||||
| ROGER, Jonathan Leslie | Geschäftsführer | AB15 | United Kingdom | British | 124423900001 | |||||||||
| ROGER, Jonathan Leslie | Geschäftsführer | AB15 | United Kingdom | British | 124423900001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NSIP (ETS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellas North Sea 2 Limited | 21. Dez. 2017 | 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London Suite 1, 3rd Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gb Gas Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NSIP (ETS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 26. März 2018 Geliefert am 26. März 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property,assets,rights and revenues,whatsoever and wheresoever,present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bond and floating charge | Erstellt am 22. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 09. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and | Erstellt am 27. Jan. 2006 Geliefert am 09. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental deed of amendment dated 23 december 2005 | Erstellt am 23. Dez. 2005 Geliefert am 10. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Dez. 2003 Geliefert am 13. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Aug. 2003 Geliefert am 04. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 01. Juli 1999 Geliefert am 14. Juli 1999 | Vollständig erf üllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document to which such borrower is a party | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juni 1998 Geliefert am 22. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for each finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all its respective present and future right and title to and interest in the charged assets by way of first floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0