RBS RETAIL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RBS RETAIL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02505372 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RBS RETAIL LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich RBS RETAIL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sanderson House Manor Road CV1 2GF Coventry |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RBS RETAIL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
RANZAU TRADING LIMITED | 01. Okt. 1999 | 01. Okt. 1999 |
RETAIL BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 13. Juli 1992 | 13. Juli 1992 |
D.C.M. RETAIL SOLUTIONS LIMITED | 25. Juli 1990 | 25. Juli 1990 |
SPEED 267 LIMITED | 24. Mai 1990 | 24. Mai 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RBS RETAIL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RBS RETAIL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Laurence Underwood als Geschäftsführer am 18. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Laurence Underwood als Sekretär am 18. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Mahoney als Geschäftsführer am 18. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mark Andrew Adamson als Sekretär am 18. Jan. 2012 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Andrew Adamson als Direktor am 18. Jan. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Adrian David Frost als Direktor am 18. Jan. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Laurence Underwood am 24. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John Mahoney am 24. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul Laurence Underwood am 24. Mai 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RBS RETAIL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMSON, Mark Andrew | Sekretär | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House | 166421510001 | |||||||
ADAMSON, Mark Andrew | Geschäftsführer | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House | England | British | Director | 54426940002 | ||||
FROST, Adrian David | Geschäftsführer | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House | England | British | Director | 74874640001 | ||||
GODWIN, Julie Louise | Sekretär | The Lodge Spratton Grange NN6 8LA Spratton Northamptonshire | British | 4174370001 | ||||||
GODWIN, Timothy Charles William | Sekretär | Orchard House 2 Fermoy Court NN7 4JP Little Brington Northamptonshire | British | 75401460001 | ||||||
STRATFORD, Peter Allan | Sekretär | 23 Meadway AL5 1JN Harpenden Hertfordshire | British | Accountant | 39401460001 | |||||
UNDERWOOD, Paul Laurence | Sekretär | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House | British | Finance Director | 81277620001 | |||||
WATSON, Steven Robert | Sekretär | Buckmore House 4 Bell Hill GU32 2DY Petersfield Hampshire | British | 25358830006 | ||||||
ALDERSLEY, Neil Mervin | Geschäftsführer | The Manor House Flecknoe CV23 8AT Rugby Warwickshire | England | British | Director | 48474080001 | ||||
BROWN, Marjorie | Geschäftsführer | 23 Rosemullion Avenue Tattenhoe MK4 3AH Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | Support & Training Director | 100993950001 | ||||
CHALLIS, Malcolm Stephen | Geschäftsführer | 6 Nostle Road Northleach GL54 3PF Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 34651280001 | |||||
CHAPMAN, Philip George | Geschäftsführer | 24 Chantry Close Huncote LE9 3AE Leicester | British | Customer Services Director | 52280770001 | |||||
FARRER, Michael Jackson | Geschäftsführer | 23 The Lawns NN18 0TA Corby Northamptonshire | British | Operations Director | 60723450001 | |||||
GODWIN, Julie Louise | Geschäftsführer | The Lodge Spratton Grange NN6 8LA Spratton Northamptonshire | British | Marketing Director | 4174370001 | |||||
GODWIN, Timothy Charles William | Geschäftsführer | Orchard House 2 Fermoy Court NN7 4JP Little Brington Northamptonshire | United Kingdom | British | Managing Director | 75401460001 | ||||
GOODALE, John Findlay | Geschäftsführer | 6 Whittemore Road NN10 0EN Rushden Northamptonshire | British | Development Manager | 39401450001 | |||||
GOODALL, Richard | Geschäftsführer | Lincoln Close Stoke Mandeville HP22 5YS Aylesbury 2 Buckinghamshire | British | Managing Director | 135065020001 | |||||
HOBSON, David | Geschäftsführer | 43 Parkhill Road NW3 2YD London | British | Sales Director | 68900240001 | |||||
JONES, Simon Francis | Geschäftsführer | 118 Grand Drive SW20 9DZ London | British | Director | 56673980001 | |||||
MAHONEY, David John | Geschäftsführer | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House | England | British | Company Director | 179523630001 | ||||
PRIESTLEY, Richard James | Geschäftsführer | 5 Irish Hill Road Kintbury RG17 9XA Hungerford Berkshire | British | Accountant | 81363210001 | |||||
ROGERSON, Paul | Geschäftsführer | Cotherstone House Marshalls Piece Stebbing CM6 3RZ Dunmow Essex | British | Technical Services Director | 58387820001 | |||||
SAUNDERS, Susan | Geschäftsführer | 73 Southwold Mansions Widley Road W9 2LF London | British | Sales Director | 49291300001 | |||||
UNDERWOOD, Paul Laurence | Geschäftsführer | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House | England | British | Finance Director | 81277620001 | ||||
WATSON, Steven Robert | Geschäftsführer | Buckmore House 4 Bell Hill GU32 2DY Petersfield Hampshire | British | Company Director | 25358830006 | |||||
WIGNALL, Peter Clifford | Geschäftsführer | 31 Long View HP4 1BY Berkhamsted Hertfordshire | England | British | Product Development Director | 52280650001 |
Hat RBS RETAIL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Sept. 1999 Geliefert am 08. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 05. März 1999 Geliefert am 16. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment and charge of copyright and design right | Erstellt am 30. Juni 1997 Geliefert am 09. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All copyrights and rights in the nature of copyright in relation to the works being: concession system point of sale software, eftpos and plastic card software, connect utility and others as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Jan. 1997 Geliefert am 13. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 04. Sept. 1992 Geliefert am 10. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from ranzau trading limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Mai 1992 Geliefert am 02. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See doc ref M267C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1991 Geliefert am 06. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal and interest due from D.C.M. holdings PLC in respect of the 10% secured loan notes 1994 from the company to kleinwort benson limited and H.I.T. investments PLC | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1991 Geliefert am 05. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany to the chargee in respect of the 15% secured loan notes 1994 made by D.C.M.holdings PLC pursuant to an instrument dated 02/12/91 subject to the terms of a deed of priority dated 2ND december 1991 the above entry has this day been amended P.jones authorised officer 18TH february 1992 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 26. Okt. 1990 Geliefert am 15. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0