RBS RETAIL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRBS RETAIL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02505372
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RBS RETAIL LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich RBS RETAIL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Sanderson House
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RBS RETAIL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RANZAU TRADING LIMITED01. Okt. 199901. Okt. 1999
    RETAIL BUSINESS SOLUTIONS LIMITED13. Juli 199213. Juli 1992
    D.C.M. RETAIL SOLUTIONS LIMITED 25. Juli 199025. Juli 1990
    SPEED 267 LIMITED24. Mai 199024. Mai 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RBS RETAIL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für RBS RETAIL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2012

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share cpremium account 09/02/2012
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Paul Laurence Underwood als Geschäftsführer am 18. Jan. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Laurence Underwood als Sekretär am 18. Jan. 2012

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David John Mahoney als Geschäftsführer am 18. Jan. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mark Andrew Adamson als Sekretär am 18. Jan. 2012

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Mark Andrew Adamson als Direktor am 18. Jan. 2012

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Adrian David Frost als Direktor am 18. Jan. 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Laurence Underwood am 24. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David John Mahoney am 24. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul Laurence Underwood am 24. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von RBS RETAIL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ADAMSON, Mark Andrew
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    Sekretär
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    166421510001
    ADAMSON, Mark Andrew
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    Geschäftsführer
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    EnglandBritishDirector54426940002
    FROST, Adrian David
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    Geschäftsführer
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    EnglandBritishDirector74874640001
    GODWIN, Julie Louise
    The Lodge
    Spratton Grange
    NN6 8LA Spratton
    Northamptonshire
    Sekretär
    The Lodge
    Spratton Grange
    NN6 8LA Spratton
    Northamptonshire
    British4174370001
    GODWIN, Timothy Charles William
    Orchard House 2 Fermoy Court
    NN7 4JP Little Brington
    Northamptonshire
    Sekretär
    Orchard House 2 Fermoy Court
    NN7 4JP Little Brington
    Northamptonshire
    British75401460001
    STRATFORD, Peter Allan
    23 Meadway
    AL5 1JN Harpenden
    Hertfordshire
    Sekretär
    23 Meadway
    AL5 1JN Harpenden
    Hertfordshire
    BritishAccountant39401460001
    UNDERWOOD, Paul Laurence
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    Sekretär
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    BritishFinance Director81277620001
    WATSON, Steven Robert
    Buckmore House
    4 Bell Hill
    GU32 2DY Petersfield
    Hampshire
    Sekretär
    Buckmore House
    4 Bell Hill
    GU32 2DY Petersfield
    Hampshire
    British25358830006
    ALDERSLEY, Neil Mervin
    The Manor House
    Flecknoe
    CV23 8AT Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Flecknoe
    CV23 8AT Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector48474080001
    BROWN, Marjorie
    23 Rosemullion Avenue
    Tattenhoe
    MK4 3AH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    23 Rosemullion Avenue
    Tattenhoe
    MK4 3AH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSupport & Training Director100993950001
    CHALLIS, Malcolm Stephen
    6 Nostle Road
    Northleach
    GL54 3PF Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    6 Nostle Road
    Northleach
    GL54 3PF Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector34651280001
    CHAPMAN, Philip George
    24 Chantry Close
    Huncote
    LE9 3AE Leicester
    Geschäftsführer
    24 Chantry Close
    Huncote
    LE9 3AE Leicester
    BritishCustomer Services Director52280770001
    FARRER, Michael Jackson
    23 The Lawns
    NN18 0TA Corby
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    23 The Lawns
    NN18 0TA Corby
    Northamptonshire
    BritishOperations Director60723450001
    GODWIN, Julie Louise
    The Lodge
    Spratton Grange
    NN6 8LA Spratton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Lodge
    Spratton Grange
    NN6 8LA Spratton
    Northamptonshire
    BritishMarketing Director4174370001
    GODWIN, Timothy Charles William
    Orchard House 2 Fermoy Court
    NN7 4JP Little Brington
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Orchard House 2 Fermoy Court
    NN7 4JP Little Brington
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManaging Director75401460001
    GOODALE, John Findlay
    6 Whittemore Road
    NN10 0EN Rushden
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    6 Whittemore Road
    NN10 0EN Rushden
    Northamptonshire
    BritishDevelopment Manager39401450001
    GOODALL, Richard
    Lincoln Close
    Stoke Mandeville
    HP22 5YS Aylesbury
    2
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lincoln Close
    Stoke Mandeville
    HP22 5YS Aylesbury
    2
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director135065020001
    HOBSON, David
    43 Parkhill Road
    NW3 2YD London
    Geschäftsführer
    43 Parkhill Road
    NW3 2YD London
    BritishSales Director68900240001
    JONES, Simon Francis
    118 Grand Drive
    SW20 9DZ London
    Geschäftsführer
    118 Grand Drive
    SW20 9DZ London
    BritishDirector56673980001
    MAHONEY, David John
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    Geschäftsführer
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    EnglandBritishCompany Director179523630001
    PRIESTLEY, Richard James
    5 Irish Hill Road
    Kintbury
    RG17 9XA Hungerford
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Irish Hill Road
    Kintbury
    RG17 9XA Hungerford
    Berkshire
    BritishAccountant81363210001
    ROGERSON, Paul
    Cotherstone House Marshalls Piece
    Stebbing
    CM6 3RZ Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    Cotherstone House Marshalls Piece
    Stebbing
    CM6 3RZ Dunmow
    Essex
    BritishTechnical Services Director58387820001
    SAUNDERS, Susan
    73 Southwold Mansions
    Widley Road
    W9 2LF London
    Geschäftsführer
    73 Southwold Mansions
    Widley Road
    W9 2LF London
    BritishSales Director49291300001
    UNDERWOOD, Paul Laurence
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    Geschäftsführer
    Manor Road
    CV1 2GF Coventry
    Sanderson House
    EnglandBritishFinance Director81277620001
    WATSON, Steven Robert
    Buckmore House
    4 Bell Hill
    GU32 2DY Petersfield
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Buckmore House
    4 Bell Hill
    GU32 2DY Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Director25358830006
    WIGNALL, Peter Clifford
    31 Long View
    HP4 1BY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    31 Long View
    HP4 1BY Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritishProduct Development Director52280650001

    Hat RBS RETAIL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Sept. 1999
    Geliefert am 08. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 1999
    Geliefert am 16. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of copyright and design right
    Erstellt am 30. Juni 1997
    Geliefert am 09. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All copyrights and rights in the nature of copyright in relation to the works being: concession system point of sale software, eftpos and plastic card software, connect utility and others as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1997
    Geliefert am 13. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1992
    Geliefert am 10. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from ranzau trading limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Mai 1992
    Geliefert am 02. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc ref M267C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 1991
    Geliefert am 06. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal and interest due from D.C.M. holdings PLC in respect of the 10% secured loan notes 1994 from the company to kleinwort benson limited and H.I.T. investments PLC
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kleinwort Benson LTD and H.I.T. Investments PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 1991
    Geliefert am 05. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee in respect of the 15% secured loan notes 1994 made by D.C.M.holdings PLC pursuant to an instrument dated 02/12/91 subject to the terms of a deed of priority dated 2ND december 1991 the above entry has this day been amended P.jones authorised officer 18TH february 1992
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • H.I.T Investments PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Okt. 1990
    Geliefert am 15. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 12. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0