CITY CLUBS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CITY CLUBS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02509209 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY CLUBS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich CITY CLUBS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CITY CLUBS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CELTHOLD LIMITED | 06. Juni 1990 | 06. Juni 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY CLUBS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY CLUBS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. März 2012
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Patrick Lee Hemmings am 06. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Clement Kay am 06. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für John David Holden am 06. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a |
Wer sind die Geschäftsführer von CITY CLUBS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN, John David | Sekretär | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | British | Accountant | 137210330001 | |||||
HEMMINGS, Patrick Lee | Geschäftsführer | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 70478960002 | ||||
KAY, John Clement | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | England | British | Director | 27891540001 | ||||
KAY, John Clement | Sekretär | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | British | 27891540001 | ||||||
LIVESEY, Frederick Joseph | Sekretär | Wal Mar Dawbers Lane, Euxton PR7 6ED Chorley Lancashire | British | Accountant | 32145610004 | |||||
LOVE, Andrew Michael | Sekretär | The Old Forge Cottage 45 High Street Markyate AL3 8PG St Albans Hertfordshire | British | 35693230001 | ||||||
SIMMONDS, Gordon Graham | Sekretär | Flat 1 20 Harrington Gardens SW7 4LS London | British | 34446930003 | ||||||
STOTT, St John | Sekretär | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | British | Accountant | 83024660001 | |||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Sekretär | 12 Clovelly Drive Hillside PR8 3AJ Southport Merseyside | British | Director | 2272770002 | |||||
HEMMINGS, Trevor James | Geschäftsführer | The Penthouse Retraite De La Mielle Route De La Haule St Brelade JE3 8BA Jersey Channel Islands | United Kingdom | British | Company Director | 65090920001 | ||||
KAY, John Clement | Geschäftsführer | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | Finance Director | 27891540001 | ||||
KENT-LEMON, Nigel William | Geschäftsführer | 29 Queensdale Road W11 4SB London | British | Company Director | 6467990001 | |||||
LIVESEY, Frederick Joseph | Geschäftsführer | Wal Mar Dawbers Lane, Euxton PR7 6ED Chorley Lancashire | British | Accountant | 32145610004 | |||||
LOVE, Andrew Michael | Geschäftsführer | The Old Forge Cottage 45 High Street Markyate AL3 8PG St Albans Hertfordshire | British | Company Director | 35693230001 | |||||
STOTT, St John | Geschäftsführer | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | United Kingdom | British | Accountant | 83024660001 | ||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Geschäftsführer | 12 Clovelly Drive Hillside PR8 3AJ Southport Merseyside | England | British | Director | 2272770002 |
Hat CITY CLUBS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 01. Okt. 1993 Geliefert am 19. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and any of the finanacing documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Mai 1993 Geliefert am 19. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3080000 and all other monies due from the comapny oto the chargee under the charge | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 12 archer street london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equitable charge | Erstellt am 06. Mai 1993 Geliefert am 19. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3080000 and ll other monies due from the comapny to the chargee under the facility agreement | |
Kurze Angaben All dividends interest and other income together with all shares and all assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee & debenture | Erstellt am 23. Juli 1990 Geliefert am 02. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and/or lydrashare limited | |
Kurze Angaben F/H 1A palace gate kensington london W8 5LS title no ln 3490. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0