HCCBH LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HCCBH LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02519405 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HCCBH LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HCCBH LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HCCBH LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BEAUMONT HOUSE PROPERTIES LIMITED | 19. Sept. 1990 | 19. Sept. 1990 |
LAW 287 LIMITED | 06. Juli 1990 | 06. Juli 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HCCBH LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HCCBH LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HCCBH LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Alexander Burrell als Direktor am 10. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 025194050012, erstellt am 12. Juni 2014 | 94 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Geraldine Josephine Gallagher als Direktor am 31. Jan. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Edward Bennison als Sekretär am 31. Jan. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Edward Bennison als Geschäftsführer am 31. Jan. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 18 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 14 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Edward Bennison als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Edward Bennison als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Doubleday als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HCCBH LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURRELL, James Alexander | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 192486560001 | ||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | Irish | Finance Director | 185108770001 | ||||
HUNTER, Gail Susan | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Human Resources Director | 89557480002 | ||||
TROY, Anthony Gerrard | Geschäftsführer | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | Director | 104500230001 | ||||
ANDERSON, Peter George | Sekretär | 23 Cheshire Road OX9 3LQ Thame Oxfordshire | British | Financial Controller | 70304810001 | |||||
BANKS, Alan Dudley | Sekretär | 4 Collison Close SG4 0RE Hitchin Hertfordshire | British | 34802920001 | ||||||
BENNISON, Matthew Edward | Sekretär | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | 161838150001 | |||||||
DOUBLEDAY, Timothy | Sekretär | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156121530001 | ||||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Sekretär | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | 185108770001 | ||||||
JOHN, Anthony Richard | Sekretär | 65 Cottenham Park Road West Wimbledon SW20 0DR London | British | 63752450001 | ||||||
MOSELEY, Rachel Heulwen | Sekretär | 7 Wimborne Close KT4 8NL Worcester Park Surrey | British | 88988890001 | ||||||
SOLOMAN, Sheila Margaret | Sekretär | 5 The Green Hardingstone NN4 7BU Northampton Northamptonshire | British | 45253560008 | ||||||
ALLNUTT, Richard Andrew James | Geschäftsführer | 16 Clapham Common West Side SW4 9AJ London | England | British | Solicitor | 69511610001 | ||||
ANDERSON, Peter George | Geschäftsführer | 23 Cheshire Road OX9 3LQ Thame Oxfordshire | British | Financial Controller | 70304810001 | |||||
BANKS, Alan Dudley | Geschäftsführer | 4 Collison Close SG4 0RE Hitchin Hertfordshire | British | Company Secretary | 34802920001 | |||||
BELLONE, Norman Edward | Geschäftsführer | Gardens Cottage Bagendon GL7 7DU Cirencester Gloucestershire | British | Director | 126414070001 | |||||
BENNISON, Matthew Edward | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | British | Company Director | 108534390002 | ||||
DAY, Mark | Geschäftsführer | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | Director | 124446000001 | ||||
DOUBLEDAY, Timothy John | Geschäftsführer | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 91011320001 | ||||
EARL, Peter Robert | Geschäftsführer | 16 Valley Close Goring RG8 0AN Reading Berkshire | British | Chartered Accountant | 86675380002 | |||||
FAULL, Michele Jean | Geschäftsführer | Renrag Flowers Bottom Lane HP27 0PZ Speen Buckinghamshire | British | Director, Tax & Treasury | 82737830001 | |||||
HAMILTON, Michael | Geschäftsführer | 23 Clarence Terrace NW1 4RD London | British | Solicitor | 103460530001 | |||||
HARRIS, Brian | Geschäftsführer | Ridge End Rowley Green Road EN5 3HH Arkley Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 82819130001 | ||||
MORRISON, Michael John | Geschäftsführer | Colston Bassett Hall Colston Bassett NG12 3FB Nottingham | United Kingdom | British | Solicitor | 8584520002 | ||||
NISBETT, Paul Sandle | Geschäftsführer | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | Company Director | 132613500001 | ||||
OWEN, Martin Neville | Geschäftsführer | 55 Greenways BR3 3NQ Beckenham Kent | British | Chartered Accountant | 72920880001 | |||||
STIMPSON, Joanne Elizabeth | Geschäftsführer | The Garden House 18 Heathway Blackheath SE3 7AN London | England | British | Accountant | 85516300001 | ||||
WILLIAMS, Brian George | Geschäftsführer | 120 Castlewood Drive Eltham SE9 1NG London | British | Director | 63752790001 |
Hat HCCBH LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 12. Juni 2014 Geliefert am 18. Juni 2014 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
English law deed of accession | Erstellt am 27. Feb. 2013 Geliefert am 01. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2011 Geliefert am 10. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession | Erstellt am 18. Juni 2007 Geliefert am 22. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 06. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 18. Dez. 2003 Geliefert am 23. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The whole of the property (including uncalled capital) the property and undertaking of the company ncluding the land and buildings k/a beaumont college priest hill old windsor berkshire t/n BK263086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture containing legal mortgage fixed and floating charges | Erstellt am 11. Juli 2002 Geliefert am 13. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation and confirmation | Erstellt am 26. Sept. 1997 Geliefert am 09. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag And varying the terms of a debenture dated 26TH september 1995 | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the property; by way of fixed charge its goodwill and uncalled capital; by way of floating charge the whole of its undertaking and property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Sept. 1995 Geliefert am 03. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the loan agreement | |
Kurze Angaben The property goodwill and uncalled capital any proceeds of insurance and rental income by way of floating charge the whole of the company's undertaking and property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 05. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company to mitsubishi bank limited as agent and trustee for the banks (as defined in the loan agreement) | |
Kurze Angaben F/H land and buildings known as beaumont college, old windsor, berkshire t/n bk 263086 (see 395 for more details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 04. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sale agreement and building contract both of even date. | |
Kurze Angaben 1) f/h property known as beuamont college old windsor, berks t/n bk 2630 86 2. fixed charge on goodwill uncalled capital and insurance proceeds. 3. floating charge on the whole of the mortgagor's undertaking property rights and future and wheresoever situate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0