ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02522258 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?
- (9220) /
Wo befindet sich ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Berkshire House 168-173 High Holborn WC1V 7AA London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALL 3 MEDIA INTERNATIONAL LIMITED | 08. Dez. 2003 | 08. Dez. 2003 |
| CHRYSALIS TELEVISION INTERNATIONAL LIMITED | 30. Okt. 1996 | 30. Okt. 1996 |
| CHRYSALIS DISTRIBUTION LIMITED | 08. Feb. 1994 | 08. Feb. 1994 |
| CHRYSALIS HOME VIDEO LIMITED | 30. Aug. 1990 | 30. Aug. 1990 |
| TIMERANDOM LIMITED | 16. Juli 1990 | 16. Juli 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | Seiten | 652a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2008 | Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007 | Seiten | AA | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed all 3 media international limite d\certificate issued on 31/08/07 | Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2006 | Seiten | AA | ||||||||||
legacy | Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | Seiten | 155(6)a | ||||||||||
legacy | Seiten | 155(6)a | ||||||||||
legacy | Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2005 | Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFEIL, John Christopher | Sekretär | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | British | 93412530001 | ||||||
| BURNS, Julian Delisle | Geschäftsführer | Chesterford Gardens Hampstead NW3 7DE London 16 | United Kingdom | British | 17986720005 | |||||
| MORRISON, Stephen Roger | Geschäftsführer | 34 Hampstead Grove NW3 6SR London | United Kingdom | British | 63326820002 | |||||
| PFEIL, John Christopher | Geschäftsführer | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | 93412530001 | |||||
| POTTERELL, Clive Ronald | Sekretär | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||
| BLESSYN, Julie | Geschäftsführer | 147(B) Holland Road West Kensington W14 8AS London | British | 43311930001 | ||||||
| PILSWORTH, Michael John | Geschäftsführer | Glebe House Church Lane LU6 2DJ Eaton Bray Bedfordshire | British | 82502160001 | ||||||
| SHARMAN, Mark Brian | Geschäftsführer | Heatherlands Salisbury Road Ower SO51 6EE Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 100171690001 | |||||
| SPURGEON, Christopher Nigel | Geschäftsführer | 91 Lonsdale Road Barnes SW13 9DA London | United Kingdom | British | 95569230001 | |||||
| WATKINS, Nicholas Revely | Geschäftsführer | Pennireve 5 Akehurst Street Roehampton SW15 5DR London | British | 41696760001 | ||||||
| WILLOUGHBY, Christina | Geschäftsführer | 47 Crown Road St Margarets TW1 3EJ Twickenham Middlesex | British | 68591600001 | ||||||
| WOHLGEMUTH, John Richard Steven | Geschäftsführer | 48d Primrose Hill Road NW3 3AA London | British | 38684180002 | ||||||
| WRIGHT, Christopher Norman | Geschäftsführer | Flat 2 87 Holland Park W11 3RZ London | United Kingdom | British | 34644910005 |
Hat ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed to a debenture | Erstellt am 28. Sept. 2006 Geliefert am 06. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 21. Juni 2005 Geliefert am 09. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 09. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 06. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0