ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02522258
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?

    • (9220) /

    Wo befindet sich ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Berkshire House
    168-173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALL 3 MEDIA INTERNATIONAL LIMITED08. Dez. 200308. Dez. 2003
    CHRYSALIS TELEVISION INTERNATIONAL LIMITED30. Okt. 199630. Okt. 1996
    CHRYSALIS DISTRIBUTION LIMITED08. Feb. 199408. Feb. 1994
    CHRYSALIS HOME VIDEO LIMITED30. Aug. 199030. Aug. 1990
    TIMERANDOM LIMITED16. Juli 199016. Juli 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    SeitenGAZ1(A)

    legacy

    Seiten652a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2008

    SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 comp act 06 12/01/2009
    RES13

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten288c

    legacy

    Seiten288c

    legacy

    Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007

    SeitenAA

    legacy

    Seiten363a

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed all 3 media international limite d\certificate issued on 31/08/07
    SeitenCERTNM

    legacy

    Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2006

    SeitenAA

    legacy

    Seiten287

    legacy

    Seiten363a

    legacy

    Seiten403a

    legacy

    Seiten403a

    legacy

    Seiten288c

    legacy

    Seiten155(6)a

    legacy

    Seiten155(6)a

    legacy

    Seiten403a

    legacy

    Seiten395

    legacy

    Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2005

    SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Sekretär
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    British93412530001
    BURNS, Julian Delisle
    Chesterford Gardens
    Hampstead
    NW3 7DE London
    16
    Geschäftsführer
    Chesterford Gardens
    Hampstead
    NW3 7DE London
    16
    United KingdomBritish17986720005
    MORRISON, Stephen Roger
    34 Hampstead Grove
    NW3 6SR London
    Geschäftsführer
    34 Hampstead Grove
    NW3 6SR London
    United KingdomBritish63326820002
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    EnglandBritish93412530001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    BLESSYN, Julie
    147(B) Holland Road
    West Kensington
    W14 8AS London
    Geschäftsführer
    147(B) Holland Road
    West Kensington
    W14 8AS London
    British43311930001
    PILSWORTH, Michael John
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    British82502160001
    SHARMAN, Mark Brian
    Heatherlands
    Salisbury Road Ower
    SO51 6EE Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Heatherlands
    Salisbury Road Ower
    SO51 6EE Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish100171690001
    SPURGEON, Christopher Nigel
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Geschäftsführer
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    United KingdomBritish95569230001
    WATKINS, Nicholas Revely
    Pennireve 5 Akehurst Street
    Roehampton
    SW15 5DR London
    Geschäftsführer
    Pennireve 5 Akehurst Street
    Roehampton
    SW15 5DR London
    British41696760001
    WILLOUGHBY, Christina
    47 Crown Road
    St Margarets
    TW1 3EJ Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    47 Crown Road
    St Margarets
    TW1 3EJ Twickenham
    Middlesex
    British68591600001
    WOHLGEMUTH, John Richard Steven
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    Geschäftsführer
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    British38684180002
    WRIGHT, Christopher Norman
    Flat 2 87 Holland Park
    W11 3RZ London
    Geschäftsführer
    Flat 2 87 Holland Park
    W11 3RZ London
    United KingdomBritish34644910005

    Hat ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Accession deed to a debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2006
    Geliefert am 06. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 21. Juni 2005
    Geliefert am 09. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 09. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chrysalis Group PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0