INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02522673 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o RUBICON PARTNERS 8-12 York Gate NW1 4QG London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
KITEGROVE LIMITED | 16. Juli 1990 | 16. Juli 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Rubicon Partners 8-12 York Gate London NW1 4QG England zum 8-12 York Gate London NW1 4QG am 28. Juli 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2B Sidings Court Doncaster South Yorkshire DN4 5NU zum 8-12 York Gate London NW1 4QG am 28. Juli 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Charles Richardson am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan Thomas Fletcher am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Fisher am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Olaf Fischer am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Jonathan Charles Richardson am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARDSON, Jonathan Charles | Sekretär | c/o Rubicon Partners York Gate NW1 4QG London 8-12 England | British | Director | 118293300001 | |||||
FISCHER, Andrew Olaf | Geschäftsführer | c/o Rubicon Partners York Gate NW1 4QG London 8-12 England | United Kingdom | German | Company Director | 70312740036 | ||||
FISHER, Ian | Geschäftsführer | c/o Rubicon Partners York Gate NW1 4QG London 8-12 England | United Kingdom | British | Company Director | 51776160030 | ||||
FLETCHER, Alan Thomas | Geschäftsführer | c/o Rubicon Partners York Gate NW1 4QG London 8-12 England | United Kingdom | British | Company Director | 14669590002 | ||||
RICHARDSON, Jonathan Charles | Geschäftsführer | c/o Rubicon Partners York Gate NW1 4QG London 8-12 England | England | British | Director | 118293300001 | ||||
FAJT, Miroslav Martin | Sekretär | 44 Crosshill Road Harts Dale New York Usa | American | 14911590001 | ||||||
HOLT, Helen Kay | Sekretär | Camelot 6 Merlin Gardens Hedge End SO30 4UA Southampton Hampshire | British | Chartered Accountant | 13706580003 | |||||
SMITH, Stephen Anthony | Sekretär | The Tudor House Week St Mary EX22 6UL Holsworthy | British | Company Director | 6780200002 | |||||
APPLEBY, Homer | Geschäftsführer | PO BOX 4529 DE19807 Greenville United States Of America | American | Lawyer | 41048760001 | |||||
BONETTI, Alessandro | Geschäftsführer | Via Castello S Felice 3-Verona Italy | Italian | Director | 40338430001 | |||||
FAJT, Miroslav Martin | Geschäftsführer | 44 Crosshill Road Harts Dale New York Usa | American | Company Director | 14911590001 | |||||
GRUNOW, John Edwin Dearden | Geschäftsführer | 6 Ford Lane FOREIGN Old Greenwich Connecticut Usa | American | Company Director | 14301290001 | |||||
HOLT, Helen Kay | Geschäftsführer | Camelot 6 Merlin Gardens Hedge End SO30 4UA Southampton Hampshire | British | Chartered Accountant | 13706580003 | |||||
HORRELL, Paul John | Geschäftsführer | 4 Richmond Court Ashton Keynes SN6 6PP Swindon Wiltshire | British | Chartered Accountant | 14483500001 | |||||
HUGGETT, Richard David John | Geschäftsführer | 113 Mapletree Avenue PO8 9BN Waterlooville Hampshire | British | Engineer | 53841290001 | |||||
QUAGLINI, Massimo | Geschäftsführer | Via Molise 41 20052 Monza (Mi) Italy | Italian | Director | 41048850001 | |||||
SIDEY, Ian Macnaughten | Geschäftsführer | April Wood Windrow Lane New Canaan Connecticut FOREIGN Usa | British | Company Director | 14911580001 | |||||
SMITH, Stephen Anthony | Geschäftsführer | The Tudor House Week St Mary EX22 6UL Holsworthy | United Kingdom | British | Company Director | 6780200002 | ||||
STAUFF, Michael Frederick | Geschäftsführer | 117 Settlers Farm Road Monroe Connecticut FOREIGN Usa | American | Company Director | 14911600001 | |||||
WONG, Ernest | Geschäftsführer | 121 North Chatsworth Avenue NY10538 Larchmont United States Of America | American | Treasurer | 40331030001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector Engineering Products Limited | 06. Apr. 2016 | York Gate NW1 4QG London 8-12 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 10. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (as therein defined) or any of them under the financing documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben All right, title and interest present and future in and to:- the right to receive payment under the acquisition documents and the keyman policies (both as defined on form 395 and within the deed). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 06. Juli 1995 Geliefert am 13. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and esch other obligor (as defined) to the chargee under the terms of the financing documents and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge over shares | Erstellt am 15. Apr. 1991 Geliefert am 03. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 1) all monies due or to become due from the company or international marine holdings, inc. To the chargee under or in respect of a note of issuance facility made on 15/4/91 and/or a note dated 15/4/91 with a face value of $75,588,605.46 and ii) all monies payable by the company under or in respect of its chargee | |
Kurze Angaben All the right, title and interest in and to the shares in the capital of benjamin priest group PLC held by the company or on its behalf on 15/4/91 --- (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit charge | Erstellt am 18. Jan. 1991 Geliefert am 25. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to all counter-indemnities in respect of guarantees given by the bank for the obligations of the company in respect of floating rate guaranteed unsecured loan notes 1992/1997 issued by the company and under or pursuant to a guarantee facility letter dated 21/12/90 (as varied amended or supplemental from time to time) | |
Kurze Angaben All cash sums deposited with national westminster bank PLC by the company under or pursuant to a guarantee facility letter dated 21/12/90. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 12. Dez. 1990 Geliefert am 31. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or international marine holdings, inc. (Imh) to the chargee under the terms of a loan (bridge loan) of up to the equivalent in U.S. dollars of sterling pounds 32 million granted by the chargee to the company pursuant to paragraph 3(b) of an amended and restated investment agreement dated 11-12-90 all monies due from the company or imh to the holder of any debenture evidencing the whole or part of the bridge loan (a secured debenture) under or in respect of such debenture. All monies due from imh to the holder of any secured debenture in respect of the guaranty given by imh in relation to such debenture and all monies due from the company under or in respect of the deed of charge. | |
Kurze Angaben All the right, title & interest in the shares in the capital of benjamin priest group PLC held by the company or on its behalf on 12.12.90 (please see doc M395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat INTERNATIONAL MARINE SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0