BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED

BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02524595
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    • Linienflugverkehr für Passagiere (51101) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Waterside
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LONDON AIRTOURS LIMITED23. Juli 199023. Juli 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2024

    • Kapital: GBP 0.20
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Waterside PO Box 365 Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB zum Waterside Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB am 04. März 2024

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Miss Sian Louise Davies am 01. Jan. 2019

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Clifton Denley als Geschäftsführer am 24. Mai 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FLEMING, Andrew Ian
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Sekretär
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    182733770001
    DAVIES, Sian Louise
    P O Box 365, Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    West Drayton
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    P O Box 365, Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    West Drayton
    United Kingdom
    EnglandBritish210550320001
    BYE, Timothy John
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    Sekretär
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    British59160780002
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    Sekretär
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    British168619310001
    ECKERT, Sabine
    44 Somervell Road
    South Harrow
    HA2 8TT Harrow
    Middlesex
    Sekretär
    44 Somervell Road
    South Harrow
    HA2 8TT Harrow
    Middlesex
    British16543120002
    PALMER, David
    Guggenbuhl 11
    Tegerfelden
    5306
    Switzerland
    Sekretär
    Guggenbuhl 11
    Tegerfelden
    5306
    Switzerland
    British50471070002
    RICHER, Charles Martin
    Brickyards
    Lyewood Common
    TN7 4DD Withyham
    East Sussex
    Sekretär
    Brickyards
    Lyewood Common
    TN7 4DD Withyham
    East Sussex
    British2121130001
    SAUNDERS, Angus Charles
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    Sekretär
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    British65848250002
    BISHOP, Michael David, Lord Glendonbrook Cbe
    52 Egerton Crescent
    SW3 2ED London
    Geschäftsführer
    52 Egerton Crescent
    SW3 2ED London
    EnglandBritish100128510001
    BURNSIDE, David Wilson Boyd
    18 Ebury Street
    SW1W 0LU London
    Geschäftsführer
    18 Ebury Street
    SW1W 0LU London
    EnglandBritish27423800001
    BYE, Timothy John
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    Geschäftsführer
    1 Duke William Mount
    The Park
    NG7 1BH Nottingham
    United KingdomBritish59160780002
    CALDWELL, Wilfrid Moores
    The Grange
    Fittleworth
    RH20 1EW Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Grange
    Fittleworth
    RH20 1EW Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish36127970001
    DENLEY, Clifton
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    United KingdomAmerican169829760001
    ELLIOT, Simon John
    Stourpaine House
    Stourpaine
    DT11 8TQ Blandford
    Dorset
    Geschäftsführer
    Stourpaine House
    Stourpaine
    DT11 8TQ Blandford
    Dorset
    United KingdomBritish29996230001
    ELLIOTT, Grahame Nicholas
    Highbury 26 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Highbury 26 Harrop Road
    Hale
    WA15 9DQ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish75330500001
    HEARD, William John
    43 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Geschäftsführer
    43 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    British63720880001
    HENNEMANN, Jorg Otto Gerhard
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    German139365650001
    HESKETH, Thomas Alexander, Lord
    Easton Neston
    NN12 8TN Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Easton Neston
    NN12 8TN Towcester
    Northamptonshire
    British40855800001
    HETHERINGTON, Desmond Brian
    Amcotts 214 Bassett Green Road
    Bassett
    SO16 3NF Southampton
    Geschäftsführer
    Amcotts 214 Bassett Green Road
    Bassett
    SO16 3NF Southampton
    British44904000001
    KAMAL, Farouk
    53 Mount Street
    W1K 2SG London
    Geschäftsführer
    53 Mount Street
    W1K 2SG London
    Swedish18497530002
    LAKEMAN, Ceri Boon
    Hedgelands House Royce Way
    West Wittering
    PO20 8LN Chichester
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Hedgelands House Royce Way
    West Wittering
    PO20 8LN Chichester
    West Sussex
    British13736440001
    MASTIN, Collin
    Southview
    Brent Pelham
    SG9 0HQ Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Southview
    Brent Pelham
    SG9 0HQ Buntingford
    Hertfordshire
    British16543130001
    MENNE, Simone
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    United KingdomGerman153979390002
    MOHTARAM, Kaddouro
    Via A Cadlolo 90
    Rome 00136
    FOREIGN Italy
    Geschäftsführer
    Via A Cadlolo 90
    Rome 00136
    FOREIGN Italy
    Lebanese41519830001
    PALMER, Robert Michael
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish125916090003
    PARRY, Hugh Archibald Pryce
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bookham Lodge
    KT11 3QJ Stoke D'Abernon
    Surrey
    EnglandBritish6992430001
    POWELL OF BAYSWATER, Charles, Lord
    1 Caroline Close
    W2 4RW London
    Geschäftsführer
    1 Caroline Close
    W2 4RW London
    EnglandBritish69244580004
    PROCK-SCHAUER, Wolfgang
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Donington Hall
    Castle Donington
    DE74 2SB Derby
    Derbyshire
    AustriaAustrian146958160001
    RICE, William Anthony
    Briarfields Cranleigh Chase
    The Common
    GU6 8SH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Briarfields Cranleigh Chase
    The Common
    GU6 8SH Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish55752930001
    RICHARDSON, David Gordon
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    Geschäftsführer
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    British50331150002
    ROMERO, Yacoub
    3 Gloucester Court
    Headstone Drive
    HA1 4UE Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    3 Gloucester Court
    Headstone Drive
    HA1 4UE Harrow
    Middlesex
    British74964500003
    SAFADI, Mohammad Ahmed
    Queen Anne House
    Queens Drive
    KT22 0PB Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Queen Anne House
    Queens Drive
    KT22 0PB Oxshott
    Surrey
    British36079770001
    SAID, Khaled Rida
    14 Quai Du Seujet
    Geneva
    Ch1201
    Switzerland
    Geschäftsführer
    14 Quai Du Seujet
    Geneva
    Ch1201
    Switzerland
    British101793620001
    SAUNDERS, Angus Charles
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Parklands
    SO21 3RH Barton Stacey
    Hampshire
    United KingdomBritish65848250002
    SIMPSON, Peter Anthony
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside PO BOX 365
    United Kingdom
    EnglandBritish195560780001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02107441
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over proceeds of aircraft slot dealing
    Erstellt am 04. Jan. 2007
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • M1 Travel Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over proceeds of aircraft slot dealing
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the receivables; and any money at any time standing to the credit of the collection account specifically relating to the receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Al Shams Holdings Limited
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 22. Juli 2005
    Geliefert am 05. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the company's right, title and interest in and to the assignor's right to receive proceeds of the insurances and any and all requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Als Irish Aircraft Leasing Msn 1690 Limited
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Engine assignment agreement
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 16. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (the assignor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest in and to the service policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag (The Assignee)
    Transaktionen
    • 16. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 16. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (the assignor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest in to under and in respect of the "assigned rights". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag (The Assignee)
    Transaktionen
    • 16. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of mortgage
    Erstellt am 22. März 2005
    Geliefert am 31. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right,title and interest,present and future,in the engine. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An assignment of insurance proceeds
    Erstellt am 22. März 2005
    Geliefert am 31. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the assignee,the facility agent,the security trustee,the lenders or any other person on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the rights,title and interest of the company in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 24. Sept. 2003
    Geliefert am 10. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the assignors right title and interest in and to the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Debis Aircraft Leasing Viii B.V.
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 06. März 2003
    Geliefert am 12. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the assignor's right to receive proceeds of the insurances and any and all requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte. LTD
    Transaktionen
    • 12. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An assignment of insurances
    Erstellt am 26. Feb. 2003
    Geliefert am 17. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's right, title, benefit and interest in and to the insurances and any requisition compensation relating to the aircraft including, but not limited to, all moneys, proceeds and payments in connection with any of the same including the right to sue for damages and any returned premiums.
    Berechtigte Personen
    • Malc Lease Three LTD (The Lessor)
    Transaktionen
    • 17. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances relating to one airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 1194
    Erstellt am 25. Apr. 2000
    Geliefert am 28. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to various agreements (as defined)
    Kurze Angaben
    All rights,title,benefit and interest in all contracts or policies of insurance and all moneys/other benefits thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte LTD
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 1998
    Geliefert am 31. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 30. Dez. 1997
    Geliefert am 16. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with the aircraft lease agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all undertaking property and assets rights and income of the company.
    Berechtigte Personen
    • Debis Aircraft Leasing Vii B.V.
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 02. Apr. 1997
    Geliefert am 10. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the aircraft lease agreements (as defined)
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Airbus Industrie Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1997
    Geliefert am 12. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement dated 30TH january 1997 and/or the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Guernroy Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement dated 18 december 1996 and the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Guernroy Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Nov. 1996
    Geliefert am 23. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreenment dated 7TH november 1996
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Guernroy Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 14. Aug. 1996
    Geliefert am 23. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All sums of money paid by the chargor to the bank pursuant to the deposit contra. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 07. Juni 1996
    Geliefert am 17. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 23. Apr. 1996
    Geliefert am 08. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement dated 19/6/95 between the company and the parties (as defined)
    Kurze Angaben
    The sum of £80,000 together with interest accrued now or to be held by natonal westminster bank PLC on an account numbered 06291325 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 21. Juli 1995
    Geliefert am 01. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Barclays bank PLC re british mediterranean airways limited gts bid deposit bid number 6119996. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 26. Juni 1995
    Geliefert am 30. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: british mediterranean airways limited currency fixed term deposit deal no. 6119996 (b) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company and (c) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 28. Dez. 1994
    Geliefert am 10. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule together with all interest from time to time accruing thereon ....... details of charged account :- barclays bank re mediterranean airways limited business premium account number 60742716. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Aircraft lease agreement
    Erstellt am 09. Aug. 1994
    Geliefert am 26. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the company`s obligations to orix aviation systems limited under the lessee documents (as defined in the lease agreement) or under any other agreement entered into, between orix aviation systems limited and the company or any of its associated or affiliated companies
    Kurze Angaben
    The "deposit" defined in the lease agreement as such sums as shall be paid to orix pursuant to clause 7.4 (a), (b) and (c) and where the context so permits,shall include the letter of credit,which is defined in the lease agreement as asny leter of credit,or,as the case may be,bank guarantee,provided by thecompany pursuant to and in accordance with cluse 7.4 including any extension`s or renewals thereof and any substitute or replacement therefor,in each case in form substance reasonably acceptable to orix.
    Berechtigte Personen
    • Orix Aviation Systems Limited
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0