BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02524595 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
- Linienflugverkehr für Passagiere (51101) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Waterside Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LONDON AIRTOURS LIMITED | 23. Juli 1990 | 23. Juli 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Waterside PO Box 365 Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB zum Waterside Speedbird Way Harmondsworth UB7 0GB am 04. März 2024 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Sian Louise Davies am 01. Jan. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clifton Denley als Geschäftsführer am 24. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEMING, Andrew Ian | Sekretär | PO BOX 365 Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth Waterside United Kingdom | 182733770001 | |||||||
| DAVIES, Sian Louise | Geschäftsführer | P O Box 365, Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth Waterside West Drayton United Kingdom | England | British | 210550320001 | |||||
| BYE, Timothy John | Sekretär | 1 Duke William Mount The Park NG7 1BH Nottingham | British | 59160780002 | ||||||
| DOSANJH, Kulbinder Kaur | Sekretär | Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth Waterside PO BOX 365 United Kingdom | British | 168619310001 | ||||||
| ECKERT, Sabine | Sekretär | 44 Somervell Road South Harrow HA2 8TT Harrow Middlesex | British | 16543120002 | ||||||
| PALMER, David | Sekretär | Guggenbuhl 11 Tegerfelden 5306 Switzerland | British | 50471070002 | ||||||
| RICHER, Charles Martin | Sekretär | Brickyards Lyewood Common TN7 4DD Withyham East Sussex | British | 2121130001 | ||||||
| SAUNDERS, Angus Charles | Sekretär | Parklands SO21 3RH Barton Stacey Hampshire | British | 65848250002 | ||||||
| BISHOP, Michael David, Lord Glendonbrook Cbe | Geschäftsführer | 52 Egerton Crescent SW3 2ED London | England | British | 100128510001 | |||||
| BURNSIDE, David Wilson Boyd | Geschäftsführer | 18 Ebury Street SW1W 0LU London | England | British | 27423800001 | |||||
| BYE, Timothy John | Geschäftsführer | 1 Duke William Mount The Park NG7 1BH Nottingham | United Kingdom | British | 59160780002 | |||||
| CALDWELL, Wilfrid Moores | Geschäftsführer | The Grange Fittleworth RH20 1EW Pulborough West Sussex | United Kingdom | British | 36127970001 | |||||
| DENLEY, Clifton | Geschäftsführer | PO BOX 365 Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth Waterside United Kingdom | United Kingdom | American | 169829760001 | |||||
| ELLIOT, Simon John | Geschäftsführer | Stourpaine House Stourpaine DT11 8TQ Blandford Dorset | United Kingdom | British | 29996230001 | |||||
| ELLIOTT, Grahame Nicholas | Geschäftsführer | Highbury 26 Harrop Road Hale WA15 9DQ Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 75330500001 | |||||
| HEARD, William John | Geschäftsführer | 43 Pall Mall SW1Y 5JG London | British | 63720880001 | ||||||
| HENNEMANN, Jorg Otto Gerhard | Geschäftsführer | Donington Hall Castle Donington DE74 2SB Derby Derbyshire | German | 139365650001 | ||||||
| HESKETH, Thomas Alexander, Lord | Geschäftsführer | Easton Neston NN12 8TN Towcester Northamptonshire | British | 40855800001 | ||||||
| HETHERINGTON, Desmond Brian | Geschäftsführer | Amcotts 214 Bassett Green Road Bassett SO16 3NF Southampton | British | 44904000001 | ||||||
| KAMAL, Farouk | Geschäftsführer | 53 Mount Street W1K 2SG London | Swedish | 18497530002 | ||||||
| LAKEMAN, Ceri Boon | Geschäftsführer | Hedgelands House Royce Way West Wittering PO20 8LN Chichester West Sussex | British | 13736440001 | ||||||
| MASTIN, Collin | Geschäftsführer | Southview Brent Pelham SG9 0HQ Buntingford Hertfordshire | British | 16543130001 | ||||||
| MENNE, Simone | Geschäftsführer | Donington Hall Castle Donington DE74 2SB Derby Derbyshire | United Kingdom | German | 153979390002 | |||||
| MOHTARAM, Kaddouro | Geschäftsführer | Via A Cadlolo 90 Rome 00136 FOREIGN Italy | Lebanese | 41519830001 | ||||||
| PALMER, Robert Michael | Geschäftsführer | Donington Hall Castle Donington DE74 2SB Derby Derbyshire | England | British | 125916090003 | |||||
| PARRY, Hugh Archibald Pryce | Geschäftsführer | Bookham Lodge KT11 3QJ Stoke D'Abernon Surrey | England | British | 6992430001 | |||||
| POWELL OF BAYSWATER, Charles, Lord | Geschäftsführer | 1 Caroline Close W2 4RW London | England | British | 69244580004 | |||||
| PROCK-SCHAUER, Wolfgang | Geschäftsführer | Donington Hall Castle Donington DE74 2SB Derby Derbyshire | Austria | Austrian | 146958160001 | |||||
| RICE, William Anthony | Geschäftsführer | Briarfields Cranleigh Chase The Common GU6 8SH Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 55752930001 | |||||
| RICHARDSON, David Gordon | Geschäftsführer | Water Lane Radwinter CB10 2TX Saffron Walden Haselbury House Essex | British | 50331150002 | ||||||
| ROMERO, Yacoub | Geschäftsführer | 3 Gloucester Court Headstone Drive HA1 4UE Harrow Middlesex | British | 74964500003 | ||||||
| SAFADI, Mohammad Ahmed | Geschäftsführer | Queen Anne House Queens Drive KT22 0PB Oxshott Surrey | British | 36079770001 | ||||||
| SAID, Khaled Rida | Geschäftsführer | 14 Quai Du Seujet Geneva Ch1201 Switzerland | British | 101793620001 | ||||||
| SAUNDERS, Angus Charles | Geschäftsführer | Parklands SO21 3RH Barton Stacey Hampshire | United Kingdom | British | 65848250002 | |||||
| SIMPSON, Peter Anthony | Geschäftsführer | Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth Waterside PO BOX 365 United Kingdom | England | British | 195560780001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Midland Limited | 06. Apr. 2016 | PO BOX 365 Speedbird Way UB7 0GB Harmondsworth Waterside United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BRITISH MEDITERRANEAN AIRWAYS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over proceeds of aircraft slot dealing | Erstellt am 04. Jan. 2007 Geliefert am 10. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over proceeds of aircraft slot dealing | Erstellt am 06. Okt. 2006 Geliefert am 20. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in and to the receivables; and any money at any time standing to the credit of the collection account specifically relating to the receivables. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of insurances | Erstellt am 22. Juli 2005 Geliefert am 05. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the company's right, title and interest in and to the assignor's right to receive proceeds of the insurances and any and all requisition compensation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Engine assignment agreement | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 16. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (the assignor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title interest in and to the service policies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 16. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (the assignor) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title interest in to under and in respect of the "assigned rights". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of mortgage | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right,title and interest,present and future,in the engine. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of insurance proceeds | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any one or more of the assignee,the facility agent,the security trustee,the lenders or any other person on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the rights,title and interest of the company in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of insurances | Erstellt am 24. Sept. 2003 Geliefert am 10. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the assignors right title and interest in and to the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of insurances | Erstellt am 06. März 2003 Geliefert am 12. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the assignor's right to receive proceeds of the insurances and any and all requisition compensation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of insurances | Erstellt am 26. Feb. 2003 Geliefert am 17. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company's right, title, benefit and interest in and to the insurances and any requisition compensation relating to the aircraft including, but not limited to, all moneys, proceeds and payments in connection with any of the same including the right to sue for damages and any returned premiums. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of insurances relating to one airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 1194 | Erstellt am 25. Apr. 2000 Geliefert am 28. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to various agreements (as defined) | |
Kurze Angaben All rights,title,benefit and interest in all contracts or policies of insurance and all moneys/other benefits thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juli 1998 Geliefert am 31. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 30. Dez. 1997 Geliefert am 16. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with the aircraft lease agreement (as defined) | |
Kurze Angaben By way of floating charge all undertaking property and assets rights and income of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 02. Apr. 1997 Geliefert am 10. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The secured obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the aircraft lease agreements (as defined) | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Jan. 1997 Geliefert am 12. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement dated 30TH january 1997 and/or the debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 1996 Geliefert am 07. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement dated 18 december 1996 and the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Nov. 1996 Geliefert am 23. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreenment dated 7TH november 1996 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 14. Aug. 1996 Geliefert am 23. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums of money paid by the chargor to the bank pursuant to the deposit contra. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 07. Juni 1996 Geliefert am 17. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 23. Apr. 1996 Geliefert am 08. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement dated 19/6/95 between the company and the parties (as defined) | |
Kurze Angaben The sum of £80,000 together with interest accrued now or to be held by natonal westminster bank PLC on an account numbered 06291325 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 21. Juli 1995 Geliefert am 01. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Barclays bank PLC re british mediterranean airways limited gts bid deposit bid number 6119996. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 26. Juni 1995 Geliefert am 30. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: british mediterranean airways limited currency fixed term deposit deal no. 6119996 (b) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company and (c) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 28. Dez. 1994 Geliefert am 10. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule together with all interest from time to time accruing thereon ....... details of charged account :- barclays bank re mediterranean airways limited business premium account number 60742716. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Aircraft lease agreement | Erstellt am 09. Aug. 1994 Geliefert am 26. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the company`s obligations to orix aviation systems limited under the lessee documents (as defined in the lease agreement) or under any other agreement entered into, between orix aviation systems limited and the company or any of its associated or affiliated companies | |
Kurze Angaben The "deposit" defined in the lease agreement as such sums as shall be paid to orix pursuant to clause 7.4 (a), (b) and (c) and where the context so permits,shall include the letter of credit,which is defined in the lease agreement as asny leter of credit,or,as the case may be,bank guarantee,provided by thecompany pursuant to and in accordance with cluse 7.4 including any extension`s or renewals thereof and any substitute or replacement therefor,in each case in form substance reasonably acceptable to orix. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0