G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD
Überblick
| Unternehmensname | G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02532816 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?
- (9999) /
Wo befindet sich G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Challenge House International Drive GL20 8UQ Tewkesbury Gloucestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AIRTIME INTERACTIVE MARKETING LTD. | 22. Aug. 1995 | 22. Aug. 1995 |
| AIR-TIME INTERACTIVE MARKETING LIMITED | 06. Feb. 1991 | 06. Feb. 1991 |
| TINYTERROR LIMITED | 20. Aug. 1990 | 20. Aug. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 17 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 17 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 19 Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 363(288) | ||
Wer sind die Geschäftsführer von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORINGTON-JONES, Gary, Mr. | Sekretär | 29 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | British | 85541780001 | ||||||
| THORINGTON-JONES, Gary, Mr. | Geschäftsführer | 29 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | England | British | 85541780001 | |||||
| WHITELOCK, Noel Keith | Geschäftsführer | 154 Cheltenham Road WR11 2LW Evesham Worcestershire | United Kingdom | British | 14940620001 | |||||
| BEERLING, Kevin Michael | Sekretär | 14 Firside Grove DA15 8WB Sidcup Kent | British | 64677850002 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Sekretär | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | 107835250001 | ||||||
| KATZ, Peter David | Sekretär | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
| MALDE, Mayur | Sekretär | 10 Ellerton Lodge N3 3QH London | Kenyan | 10737440001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Sekretär | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | British | 116252510001 | ||||||
| CAMPBELL, Sylvia | Geschäftsführer | 18 Forth Place NE1 4EU Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 53211510001 | |||||
| FIELDER, John David | Geschäftsführer | Flat 1 39 Portland Place W17 3AG London | British | 21659890001 | ||||||
| GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley | Geschäftsführer | 15 Tantallon Court Woodstone Village DH4 6TJ Houghton Le Spring County Durham | British | 89929500001 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Geschäftsführer | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||
| MCNAIR, Iain | Geschäftsführer | 23 Mycenae Road SE3 7SF London Greater London | British | 85499250001 | ||||||
| MCNAIR, John | Geschäftsführer | 7 Westcombe Park Road SE3 7RE London | British | 61297520001 | ||||||
| MILLS, Mark Richard | Geschäftsführer | 3 Neptune Court FY4 5LZ Blackpool Lancashire | United Kingdom | British | 10402540008 | |||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Geschäftsführer | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | England | British | 116252510001 | |||||
| NWOSU HOPE, Nigel Peter | Geschäftsführer | Lakewood Minsteracres DH8 9RR Consett County Durham | United Kingdom | British | 64095750001 | |||||
| SARGENT, Christian William Lance | Geschäftsführer | 3 Folly Cottages Herts Lane RG20 9HF Burghclere Hampshire | British | 95077810001 | ||||||
| SMYTH, Peter Francis | Geschäftsführer | Flat 2 62 Queens Gate SW7 5JP London | Irish | 63863190002 |
Hat G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed to an intercreditor deed | Erstellt am 21. Feb. 2006 Geliefert am 07. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By clause 5.1 (turnover: turnover obligations) of the deed until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments, it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the chargee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the chargee, the additional obligor shall hold the same on trust for the application by the chargee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Syndicated debenture | Erstellt am 21. Feb. 2006 Geliefert am 07. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Juli 2005 Geliefert am 15. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 10. Juni 2004 Geliefert am 16. Juni 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies (includinf interest accrued thereto) standing to the credit of the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Aug. 2002 Geliefert am 13. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or airtime group holdings limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 15. Mai 2000 Geliefert am 19. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £14,500.00 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The separate earning deposit account with a deposit of £14,500. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 15. Mai 2000 Geliefert am 18. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 21 march 1996 or the rent deposit deed | |
Kurze Angaben The monies deposited in an account at unity trust bank PLC and all monies withdrawn from that deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0