G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameG2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02532816
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?

    • (9999) /

    Wo befindet sich G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Challenge House
    International Drive
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AIRTIME INTERACTIVE MARKETING LTD.22. Aug. 199522. Aug. 1995
    AIR-TIME INTERACTIVE MARKETING LIMITED06. Feb. 199106. Feb. 1991
    TINYTERROR LIMITED20. Aug. 199020. Aug. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    13 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    17 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    9 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    19 SeitenAA

    legacy

    Seiten363(288)

    Wer sind die Geschäftsführer von G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Sekretär
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    British85541780001
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish85541780001
    WHITELOCK, Noel Keith
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish14940620001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Sekretär
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    British64677850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Sekretär
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    MALDE, Mayur
    10 Ellerton Lodge
    N3 3QH London
    Sekretär
    10 Ellerton Lodge
    N3 3QH London
    Kenyan10737440001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Sekretär
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    CAMPBELL, Sylvia
    18 Forth Place
    NE1 4EU Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    18 Forth Place
    NE1 4EU Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish53211510001
    FIELDER, John David
    Flat 1
    39 Portland Place
    W17 3AG London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    39 Portland Place
    W17 3AG London
    British21659890001
    GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    British89929500001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    MCNAIR, Iain
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    Geschäftsführer
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    British85499250001
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Geschäftsführer
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MILLS, Mark Richard
    3 Neptune Court
    FY4 5LZ Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    3 Neptune Court
    FY4 5LZ Blackpool
    Lancashire
    United KingdomBritish10402540008
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Geschäftsführer
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    NWOSU HOPE, Nigel Peter
    Lakewood
    Minsteracres
    DH8 9RR Consett
    County Durham
    Geschäftsführer
    Lakewood
    Minsteracres
    DH8 9RR Consett
    County Durham
    United KingdomBritish64095750001
    SARGENT, Christian William Lance
    3 Folly Cottages
    Herts Lane
    RG20 9HF Burghclere
    Hampshire
    Geschäftsführer
    3 Folly Cottages
    Herts Lane
    RG20 9HF Burghclere
    Hampshire
    British95077810001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Geschäftsführer
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002

    Hat G2 INTEGRATED SOLUTIONS LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Accession deed to an intercreditor deed
    Erstellt am 21. Feb. 2006
    Geliefert am 07. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By clause 5.1 (turnover: turnover obligations) of the deed until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments, it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the chargee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the chargee, the additional obligor shall hold the same on trust for the application by the chargee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Syndicated debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2006
    Geliefert am 07. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustee for Thebeneficiaries
    Transaktionen
    • 07. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 10. Juni 2004
    Geliefert am 16. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies (includinf interest accrued thereto) standing to the credit of the account.
    Berechtigte Personen
    • Helical (Westfields) Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 13. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or airtime group holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Mai 2000
    Geliefert am 19. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £14,500.00 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The separate earning deposit account with a deposit of £14,500. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Malcolm Robert Wallace and William Ignatious Etherington
    Transaktionen
    • 19. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Mai 2000
    Geliefert am 18. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 21 march 1996 or the rent deposit deed
    Kurze Angaben
    The monies deposited in an account at unity trust bank PLC and all monies withdrawn from that deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Malcolm Robert Wallace
    • William Ignacious Etheringtonthe Trustees for the Time Being of the Transport Salaried Staffs Association
    Transaktionen
    • 18. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0