NTL DARLINGTON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNTL DARLINGTON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02533674
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NTL DARLINGTON LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich NTL DARLINGTON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NTL DARLINGTON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COMCAST DARLINGTON LIMITED23. Juni 199423. Juni 1994
    AVALON CABLECOMMS DARLINGTON LIMITED07. Dez. 199307. Dez. 1993
    NYNEX CABLECOMMS DARLINGTON LIMITED27. Sept. 199127. Sept. 1991
    BRITANNIA CABLESYSTEMS DARLINGTON LIMITED08. Feb. 199108. Feb. 1991
    CHARCO 346 LIMITED22. Aug. 199022. Aug. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL DARLINGTON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NTL DARLINGTON LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NTL DARLINGTON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 Seiten4.71

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 21. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 03. Aug. 2015

    LRESSP

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 93,623
    SH01

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    3 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    22. Apr. 2014This document is a duplicate of the AP01 registered on 09/04/2014 for Mine Hifzi

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    97 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 93,623
    SH01

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von NTL DARLINGTON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    151344030001
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    FLEISSIG, Clive Allen
    10813 Wellworth Avenue
    90024 Los Angeles
    California
    United States Of America
    Sekretär
    10813 Wellworth Avenue
    90024 Los Angeles
    California
    United States Of America
    American37041320001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    MARTINE, Michela Alexa
    21 The Ridgeway
    Wimbledon
    SW19 London
    Sekretär
    21 The Ridgeway
    Wimbledon
    SW19 London
    British31528960001
    MCLEAN, Gregory Joseph
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    Sekretär
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    British33612180001
    PHILLIPS, Derek Norman
    10 Lawrence Crescent
    Richmond
    DL10 5QE Darlington
    North Yorkshire
    Sekretär
    10 Lawrence Crescent
    Richmond
    DL10 5QE Darlington
    North Yorkshire
    British51107720001
    REPP, Paul Howard
    3 Eagle Place
    Roland Way
    SW7 3RG London
    Sekretär
    3 Eagle Place
    Roland Way
    SW7 3RG London
    British36232420001
    RUTH, John Charles
    Pembridge Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    Sekretär
    Pembridge Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    British39686940001
    THOM, Alastair Stephen
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    Sekretär
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    British9591260001
    WEARDEN, James
    2 Greyfriars Close
    B92 7DR Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    2 Greyfriars Close
    B92 7DR Solihull
    West Midlands
    British15069160001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRENNAN, Mark Daniel
    21 Evelyn Gardens
    SW7 3BE London
    Geschäftsführer
    21 Evelyn Gardens
    SW7 3BE London
    British34687850001
    CAMPBELL, Gerald Daniel
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    Geschäftsführer
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    American48066760001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CONNELL, Eugene Patrick
    9 Rushmere Place Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5RP London
    Geschäftsführer
    9 Rushmere Place Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5RP London
    American34358920001
    DAVIES, Richard James
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    American45182540001
    DORMAND, John Donkin, Right Honourable Lord
    Lynton Stockton Road
    Easington
    SR8 3AZ Peterlee
    County Durham
    Geschäftsführer
    Lynton Stockton Road
    Easington
    SR8 3AZ Peterlee
    County Durham
    British38029030001
    FLEISSIG, Clive Allen
    10813 Wellworth Avenue
    90024 Los Angeles
    California
    United States Of America
    Geschäftsführer
    10813 Wellworth Avenue
    90024 Los Angeles
    California
    United States Of America
    American37041320001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GLASER, Norman
    9320 Los Prados Lane
    93923 Carmel
    California
    Usa
    Geschäftsführer
    9320 Los Prados Lane
    93923 Carmel
    California
    Usa
    American37034210001
    GOWEN, Wayne Lyle
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British39694410001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    ITSKOWITCH, Stanley Sylvan
    969 Hilgard Avenue
    90024 Los Angeles
    California
    Usa
    Geschäftsführer
    969 Hilgard Avenue
    90024 Los Angeles
    California
    Usa
    American37034930002
    KAGAN, Paul Franklin
    25849 Hatton Road
    Carmel 93923
    FOREIGN California
    Usa
    Geschäftsführer
    25849 Hatton Road
    Carmel 93923
    FOREIGN California
    Usa
    American38486040002
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    LAWLEY, Ronald Edward
    28 Hurst Park
    GU29 0BP Midhurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    28 Hurst Park
    GU29 0BP Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish121475980001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002

    Hat NTL DARLINGTON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2004
    Geliefert am 30. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 30. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Jan. 1998
    Geliefert am 23. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due, owing or incurred to the chargee in its capacity as security trustee by the company and/or all or any of the other companies named therein under or pursuant to the agreement and/or the composite guarantee and debenture and/or the security trust deed and/or any of the other security documents, all obligations and liabilities due owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein to the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements, and to the bond providers, if any (or any of them) in respect of any indemnity from the company and/or all or any of the other companies named therein issued in connection with the bond provision arrangements
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NTL DARLINGTON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Sept. 2016Aufgelöst am
    03. Aug. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0