LTC RESIDENTIAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLTC RESIDENTIAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02534762
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PREDATOR ONE LIMITED24. Aug. 199024. Aug. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    15 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2015

    17 SeitenAA

    legacy

    38 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 26. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Gwynne Smith am 01. Aug. 2015

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share premium account 16/12/2014
    RES13

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2014

    17 SeitenAA

    legacy

    34 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 03. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 2,500,011
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Gwynne Smith am 01. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Geoffrey John Griggs am 01. Sept. 2014

    1 SeitenCH03

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 025347620030 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2013

    17 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRIGGS, Geoffrey John
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Sekretär
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    British16580510001
    MATTHEWS, Timothy Ian
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Geschäftsführer
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    EnglandBritish108845860001
    SMITH, Richard Gwynne
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Geschäftsführer
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    United KingdomBritish168772030001
    DEARLING, Lynne Joyce
    55 Huntingdon Road
    N2 9DX London
    Sekretär
    55 Huntingdon Road
    N2 9DX London
    Welsh60000900001
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Sekretär
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Sekretär
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    SWEETLAND, Duncan Barrington John
    Periwinkle Cottage
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Periwinkle Cottage
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    British46467820005
    WILKES, Rupert Thomas James
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    Sekretär
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    British71363620004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    HARE, Nicholas Patrick
    Manor Farm
    Culkerton
    GL8 8SS Tetbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Culkerton
    GL8 8SS Tetbury
    Gloucestershire
    British34878680001
    HAWKINS, Christopher James
    20 Northweald Lane
    KT2 5GW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    20 Northweald Lane
    KT2 5GW Kingston Upon Thames
    Surrey
    British50135940001
    LO, Robert Anthony
    113 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    113 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DR London
    British900005400001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    EnglandBritish47952140001
    WEBB, Maurice Clifford
    32b Argyle Street
    WC1H 8EN London
    Geschäftsführer
    32b Argyle Street
    WC1H 8EN London
    British2664040002
    WILKES, Rupert Thomas James
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish71363620004

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LTC RESIDENTIAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Old Church Street
    SW3 5BY London
    28
    England
    01. Aug. 2016
    Old Church Street
    SW3 5BY London
    28
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortUnited Kingdom
    Registrierungsnummer02570517
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat LTC RESIDENTIAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Mai 2013
    Geliefert am 13. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Cutty sark house, undine road, millwall, london E14 9UW (registered at the land registry with title number EGL456067). Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The LLP Property Pcc Limited on Behalf of Eaton Active Special Opportunity Property Fund
    Transaktionen
    • 13. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 20 vale court mallord street london t/n NGL321315. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a oakview apartments 10-12 benhill road sutton t/n SGL622410 and SY258250. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a gwynn house 94 lower sloane street london t/n NGL247144. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H flat 39 daver court chelsea manor street london t/n NGL343575. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 34 daver court chelsea manor street london t/NNGL190033. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a flat 2 14 finborough road london t/n NGL381483. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a cutty sark house undine road london t/n EGL456067 l/h first floor flat 4 and parking space cutty sark house t/n EGL256120 l/h ground floor flat 1 and parking space cutty sark house t/n EGL256550 for further details of the properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 11. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 20. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All its right title benefit and interest in and to the rental income.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 20. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property 5 terrace road maidstone kent t/no K235446; 60 allen street maidstone kent K347662; 62 allen street maidstone kent t/no K209446 (for further property charged refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Mai 2003
    Geliefert am 16. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 wolverton avenue kingston-upon-thames surrey KT2 7QF t/no SGL626239.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. März 2003
    Geliefert am 18. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £56,191.38 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a 22 kershaw crescent halifax.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2003
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £46,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    58 darley road,liversedge,bradford WF15 6QB.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2003
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £41,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    65 chapel street,eccleshill,bradford BD2 2DA.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £81,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    40 christie close walderslade chatham kent ME5 7NG.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 04. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £160,599.90
    Kurze Angaben
    29 bishops road london.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 04. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £80,500 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    79 ashfields pitsea essex.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 28. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property with title no.LN59231,kensington and chelsea,gt.london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Jan. 2001
    Geliefert am 24. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental account charge
    Erstellt am 12. Jan. 2001
    Geliefert am 24. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the charged accounts being:caledonian 00698665 (bank of scotland) and the secured amounts and all the entitlements to interest and the other rights and benefits in the connection with the secured amounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 30. März 2000
    Geliefert am 06. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The company full title guarantee all its right title benefit and interest all rent or other sums of money. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 2000
    Geliefert am 06. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as 14 finborough road london SW10 title number NGL381483, 1 cutty sark house, london E14 title number EGL256550, 2 cutty sark house, london E14 title number EGL273580 for further property details see ch microfiche,.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 30. März 2000
    Geliefert am 06. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facilities agreement dated 10 july 1998
    Kurze Angaben
    Full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juli 1998
    Geliefert am 22. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0