IBREND LIMITED
Überblick
Unternehmensname | IBREND LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02536652 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IBREND LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich IBREND LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Devonshire House 60 Goswell Road EC1M 7AD London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IBREND LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IBREND LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sloane Square House 1 Holbein Place London SW1W 8NS zum Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD am 08. Feb. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Michael Woods am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gerard Mikael Versteegh am 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Andrew Scott als Geschäftsführer am 10. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Michael Woods am 02. Okt. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Andrew Scott am 10. Okt. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rb Secretariat Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IBREND LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSTEEGH, Gerard Mikael | Geschäftsführer | 1 Holbein Place SW1W 8NS London Sloane Square House United Kingdom | United Kingdom | Swedish | Company Director | 29856680002 | ||||||||
WOODS, Andrew Michael | Geschäftsführer | 1 Holbein Place SW1W 8NS London Sloane Square House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 31120770008 | ||||||||
RB SECRETARIAT LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Third Floor 20 Primrose Street EC2A 2RS London The Broadgate Tower England |
| 900006270001 | ||||||||||
SCOTT, James Andrew | Geschäftsführer | Ferry Lane Mill End RG9 3BL Hambleden Thamesfield Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 79599370004 | ||||||||
SHALE, Nicola Diana | Geschäftsführer | The Garden Cottage Cornbury Park OX7 3EN Charlbury Oxfordshire | British | Company Director | 31303490001 | |||||||||
SODERBERG, Ragnar Axel | Geschäftsführer | Sobro Stureplan 2 11435 Stockholm Sweden | Swedish | Businessman | 35533380006 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für IBREND LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
04. Sept. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat IBREND LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of subordination | Erstellt am 03. Aug. 2004 Geliefert am 06. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All sums liabilities and obligations (the subordinated liabilities). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge pursuant to a mortgage debenture dated 10 march 1999 | Erstellt am 26. Juli 2001 Geliefert am 30. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that freehold land and buildings at wetherby road boroughbridge north yorkshire and all buildings fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery from time to time on any such freehold/leasehold and other immovable property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge pursuant to a mortgage debenture dated 10TH march 1999 | Erstellt am 04. Mai 2001 Geliefert am 09. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land being land and buildings on the south east side of kiln lane stallingborough - HS287445; f/h land being wakefield house marsh way wakefield - WYK546238; f/h land being 43 to 51 (odd numbers) station road 4 to 24 (even numbers) and the site of 2, 26 and 28 mark street 1,3 and 5 and the sites of 23 and 25 bradley street sandiacre - DY3787 see 395 for further properties and all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge pursuant to a mortgage debenture dated 10 march 1999 | Erstellt am 24. Aug. 2000 Geliefert am 30. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land known as talgarth house,llantarnam park industrial estate,cwmbran,tor-faen,torfaen; t/no WA865325; all buildings fixtures and all plant machinery thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 16. März 2000 Geliefert am 17. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 31 station lane witney oxfordshire and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time and all plant and machinery (excluding stock in trade). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge pursuant to a debenture dated 10TH march 1999 issued by the company | Erstellt am 21. Mai 1999 Geliefert am 03. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed legal mortgage f/h land and buildings on the south west side of cawdor street salford greater manchester t/n-LA319691 and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time on any such property,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge (pursuant to a debenture dated 10 march 1999) | Erstellt am 07. Apr. 1999 Geliefert am 12. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property being land lying to the west side of burnt tree k/a burnt tree house dudley t/n SF57524 and all buildings fixtures plant machinery and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 25. März 1999 Geliefert am 29. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement constituted by the letter from the lender to the company dated 17 february 1999 which letter was accepted by the company on 25 february 1999 | |
Kurze Angaben Freehold property k/a 35 36 and 37 great charles street birmingham t/n WK134995 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all plant machinery vehicles computers and office and other equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 19. März 1999 Geliefert am 29. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement constituted by the letter from the lender to the company dated 17 february 1999 which letter was accepted by the company on 25 february 1999 | |
Kurze Angaben Freehold property k/a units 1 to 6 high march industrial estate daventry t/n NN205023 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all plant machinery vehicles computers and office and other equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 10. März 1999 Geliefert am 12. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a 29 london road l/b of bromley t/no: K126395. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge and adherence | Erstellt am 30. Dez. 1993 Geliefert am 06. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 6TH august 1992 | |
Kurze Angaben F/H property k/a wakefield house marsh way wakefield yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Aug. 1992 Geliefert am 20. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a units b & c mark st., Sandiacre, derbyshire t/no. DY3787. L/h property k/a wakefield house marsh way wakefield W. yorkshire t/no. WYK122654. F/h property k/a kiln lane trading estate stallingborough grimsby t/no. HS191799 and f/h prosperty k/a units a b and c bilton way lutterworth leics. T/nos.LT98782 and LT231282 see form 395 ref.M8L for full details. Fixed charge over all rental income and. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Okt. 1991 Geliefert am 14. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units a b f highfield road ind est highfield road worsley salford t/n GM464591 and all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery see 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Okt. 1991 Geliefert am 14. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of security | Erstellt am 29. Okt. 1991 Geliefert am 14. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All amounts which are now or which may from time to time hereafter be standing to the credit of the companys account with the bank and all interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 14. Aug. 1991 Geliefert am 29. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of even date | |
Kurze Angaben The sums from time to time standing to the credit of the account of the company with the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Aug. 1991 Geliefert am 29. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A first legal charge over all f/h property k/a wakefield house, marwsh way, wakefield, west yorkshire, title no. Wyk 122654. fixed and floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Dez. 1990 Geliefert am 03. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 20TH december 1990 | |
Kurze Angaben F/H property k/a units b and c mark st industrial estate sandiacre derbyshire being part of property title no dy 3787. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat IBREND LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0