FW100 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FW100 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02536658 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FW100 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FW100 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CULINA GROUP LIMITED Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Shropshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FW100 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OCTAVIAN LIMITED | 02. Nov. 1990 | 02. Nov. 1990 |
| LERMONDIAL LIMITED | 04. Sept. 1990 | 04. Sept. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FW100 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FW100 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christian Lee Price als Direktor am 24. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Arthur Thomas Michael Naylor als Geschäftsführer am 13. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Nigel Stephen Jury als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Naylor als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Thomas Arthur Naylor als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Jury als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FW100 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURY, Nigel Stephen | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | 186262490001 | |||||||
| JURY, Nigel Stephen | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 169320190001 | |||||
| PRICE, Christian Lee | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire | United Kingdom | British | 205439820001 | |||||
| VAN MOURIK, Thomas | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | England | Dutch | 108562780001 | |||||
| DANIEL, Pauline Theresa | Sekretär | Apt 97 New Caledonian Wharf SE16 1TW London | British | 53340350001 | ||||||
| HEATH, Richard Martin | Sekretär | 41 Lancer Way CM12 0XA Billericay Essex | British | 57945380001 | ||||||
| JURY, Nigel Stephen | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | 169503150001 | |||||||
| NAYLOR, Michael Thomas Arthur | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | 176032530001 | |||||||
| O'BRIEN, Vincent | Sekretär | Haslemere Avenue EN4 8EY Barnet 17 Hertfordshire United Kingdom | Irish | 138590150001 | ||||||
| PARK, Stewart James | Sekretär | 26 Goldington Road MK40 3DY Bedford Bedfordshire | British | 63108020001 | ||||||
| TAYLOR, Gregory Robert | Sekretär | 37 Clifford Road EN5 5PD New Barnet Hertfordshire | British | 38832300001 | ||||||
| BARTLETT, Martin James | Geschäftsführer | 46 Stonechat Road CM11 2NZ Billericay Essex | United Kingdom | British | 29231020002 | |||||
| BRANNIGAN, Stephen Gerard James | Geschäftsführer | Glanconway Argyle Gardens RM14 3HD Upminster Essex | British | 16797550001 | ||||||
| DANIEL, Pauline Theresa | Geschäftsführer | Apt 97 New Caledonian Wharf SE16 1TW London | British | 53340350001 | ||||||
| DANIEL, Stephen Charles | Geschäftsführer | The Byre House Great Fowle Hall Darman Lane TN12 6PW Paddock Wood Kent | British | 43976670001 | ||||||
| EVANS, Darrell Leigh | Geschäftsführer | 248 Kentish Town Road NW5 2AB London | British | 11743950001 | ||||||
| FINLAYSON-GREEN, Anthony Raymond | Geschäftsführer | 141 Three Bridges Road Three Bridges RH10 1JT Crawley Woodcroft West Sussex | United Kingdom | British | 128136310001 | |||||
| GREER, Laurence Arthur | Geschäftsführer | 2 Saunders Grove SN13 9XG Corsham Wiltshire | United Kingdom | British | 16797530001 | |||||
| HEATH, Richard Martin | Geschäftsführer | 41 Lancer Way CM12 0XA Billericay Essex | British | 57945380001 | ||||||
| JAGGER, Nigel Mark | Geschäftsführer | Maison De Bas Rue Degypte Trinity Jersey Channel Islands | Channel Islands | British | 202830830001 | |||||
| LAINAS, Michael Constantine | Geschäftsführer | Seeleys Farmhouse Seeleys Road HP9 1TW Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 15284390002 | |||||
| NAYLOR, Arthur Thomas Michael | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 169270540001 | |||||
| O'BRIEN, Vincent | Geschäftsführer | Haslemere Avenue EN4 8EY Barnet 17 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138590150001 | |||||
| PEARSON, Jeremy Hugh | Geschäftsführer | The Grove Cottage Hartham SN13 0PZ Corsham Wiltshire | British | 16797510001 | ||||||
| SPIBEY, George Arthur | Geschäftsführer | 5 Spicers Close Claverley WV5 7BY Wolverhampton West Midlands | British | 16797520001 | ||||||
| STANTON, Jeffrey | Geschäftsführer | 9 Brownswood Road HP9 2NU Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 41676230001 | |||||
| TAYLOR, Gregory Robert | Geschäftsführer | 37 Clifford Road EN5 5PD New Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 38832300001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FW100 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culina Group Limited | 06. Apr. 2016 | Shrewsbury Road TF9 3SQ Market Drayton Tern Valley Business Park Shropshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FW100 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 07. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a victoria warehouse, 40 victoria way, charlton, london t/no. SGL94429 and f/h property k/a no.2 Sub depot, eastlays, gastard, corsham, wiltshire t/no. WT111303. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a warehouse at 40 victoria way charlton london SE7 t/n sgl 94429 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a vaults and warehouses at gastard corsham wiltshire (known as E. eastlays complex) t/n wt 111303 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agency agreement | Erstellt am 21. Feb. 1994 Geliefert am 25. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this agency agreement | |
Kurze Angaben All the right title and interest of the company in each property the subject of a purchase agreement (as therein defined) including the benefit of each such purchase agreement and all fixtures and fittings, and other assets and rights the subject of such purchase agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Feb. 1991 Geliefert am 01. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at gastard near corsham, wiltshire-k/a no 2 sub depot eastleys, containing 41.5 acres of land. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture under registered pursuant to an order of court dated 5-6-91) | Erstellt am 31. Jan. 1991 Geliefert am 14. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property at 40 victoria way, charlton, london SE7 7QS title number sgl 94429 all that f/h piece or parcel of land k/a no. 2 sub depot, eastlays st gastard nr corsham wiltshire (see gorm 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1991 Geliefert am 12. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Victoria warehouse 40 victoria way, charlton, l/b of greenwich title no sgl 94429. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 1991 Geliefert am 12. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0