CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED

CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02538184
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    • Vorschule (85100) / Erziehung

    Wo befindet sich CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o C/O TREETOPS NURSERIES LIMITED
    1 St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DUNMAR (NURSERIES) LIMITED07. Sept. 199007. Sept. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 07. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Charles Edmund Patrick Eggleston als Direktor am 11. Sept. 2013

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Hancock als Geschäftsführer am 10. Mai 2013

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    3 SeitenAA

    Rücktritt eines Auditors

    2 SeitenAA03

    Beendigung der Bestellung von Alan James Proto als Geschäftsführer am 18. Sept. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Clare Elizabeth Wilson als Geschäftsführer am 05. Apr. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Clare Elizabeth Wilson als Direktor am 29. März 2012

    2 SeitenAP01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Amendment and restatement agmnt 29/02/2012
    RES13

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Mrs Clare Elizabeth Wilson als Direktor am 17. Jan. 2012

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Hancock als Direktor am 17. Jan. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nexus Management Services Limited als Sekretär am 09. Jan. 2012

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Nexus Management Services Ltd 2nd Floor Griffin House West Street Woking Surrey GU21 6BS United Kingdom am 11. Jan. 2012

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILSON, Clare Elizabeth
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    165810620001
    EGGLESTON, Charles Edmund Patrick
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish88878580004
    WILSON, Clare Elizabeth
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish148642230002
    DUCKITT, David Nicholas
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    Derbyshire
    British39020250001
    FINNITY, Janet Elizabeth
    Chestnut House
    Hollington Ashbourne
    DE6 3GB Derby
    Sekretär
    Chestnut House
    Hollington Ashbourne
    DE6 3GB Derby
    British90883620001
    FOSTER, Caroline Ann
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Sekretär
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    British55169500001
    FOSTER, Paul Martin
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    Sekretär
    12 Earls Crescent
    Oakwood
    DE21 2QB Derby
    British39471300001
    FOSTER, Paul Martin
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    Sekretär
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    British16609250002
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Floor Griffin House
    West Street
    GU21 6BS Woking
    2nd
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor Griffin House
    West Street
    GU21 6BS Woking
    2nd
    Surrey
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4187765
    57253330002
    TLT SECRETARIES LIMITED
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Sekretär
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    77278550001
    FOSTER, Jacqueline
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Dunmar House
    Cloves Hill
    DE7 6DH Morley
    Derbyshire
    British19372380001
    FOSTER, Paul Martin
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Little Knowle
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish16609250003
    HANCOCK, David
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish166213530001
    PROTO, Alan James
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish41906780005
    WILSON, Clare Elizabeth
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o C/O Treetops Nurseries Limited
    St. James Court, Friar Gate
    DE1 1BT Derby
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish148642230002
    WINTERBOTHAM, David Mark
    1 Mulberries Court
    Allestree
    DE22 2HL Derby
    Geschäftsführer
    1 Mulberries Court
    Allestree
    DE22 2HL Derby
    EnglandBritish47185690001

    Hat CASHEW CHILDRENS NURSERIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of debenture
    Erstellt am 28. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Littlemoor house littlemoor road pudsey t/n WYK723357 and WYK730712. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Aug. 2003
    Geliefert am 30. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Mai 2002
    Geliefert am 04. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a littlemoor house littlemoor road pudsey leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Okt. 2001
    Geliefert am 06. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all that l/h property k/a treetops day nursery and kindergarten, chapel lane, wythall, worcestershire B47 6AJ.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Okt. 2001
    Geliefert am 06. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all that l/h property k/a treetops day nursery and kindergarten, chesterfield road, matlock t/n DY310406.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2001
    Geliefert am 06. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Aug. 1998
    Geliefert am 04. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0