MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED

MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMUREHOUSE PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02540696
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    61 Thames Street
    SL4 1QW Windsor
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MALTRICH LIMITED18. Sept. 199018. Sept. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 186,002
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Derek Maurice Joseph am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Gatehouse, 2 Park Street Windsor Berkshire SL4 1LU am 16. März 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Derek Maurice Joseph am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KERR, James Michael
    Woodmancott Close
    RG12 0XU Bracknell
    25
    Berkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Woodmancott Close
    RG12 0XU Bracknell
    25
    Berkshire
    United Kingdom
    BritishFinance Director64287560003
    JOSEPH, Derek Maurice
    Tempus Wharf
    29 Bermondsey Wall West
    SE16 4RW London
    Flat 8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tempus Wharf
    29 Bermondsey Wall West
    SE16 4RW London
    Flat 8
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director40393740002
    TAYLOR, Denis Newman
    8 Syke Cluan
    SL0 9EH Iver
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    8 Syke Cluan
    SL0 9EH Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor57777760001
    BOAKES, Timothy David
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    Sekretär
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant38948010001
    BUTTERFIELD, Christopher Alan
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    Sekretär
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    British7649100002
    BOAKES, Timothy David
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant38948010001
    BOOLER, Michael David
    55 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    55 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    BritishIndependent Financial Adviser23889810001
    BUTTERFIELD, Christopher Alan
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    Geschäftsführer
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    EnglandBritishChartered Accountant7649100002
    CLEAVER, Robert John
    Highland Cottage Giddy Lake
    BH21 2QT Wimborne
    Dorset
    Geschäftsführer
    Highland Cottage Giddy Lake
    BH21 2QT Wimborne
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director55300920001
    COURT, Robert Leonard
    Southdown House Southdown Road
    Shawford
    SO21 2BX Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Southdown House Southdown Road
    Shawford
    SO21 2BX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Surveyor7767540001
    KEYS, Brian Sarel
    Island Covert
    Steep
    GU32 1AE Petersfield
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Island Covert
    Steep
    GU32 1AE Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Surveyor28540060001
    LIFFORD, Edward James Wingfield, The Viscount
    Field House
    Hursley
    SO21 2LE Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Field House
    Hursley
    SO21 2LE Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishStockbroker14020560001

    Hat MUREHOUSE PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third party legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 42 pendle crescent the wells road nottingham nottinghamshire t/n NT262937. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 40 pendle crescent the wells road nottingham nottinghamshire t/n NT262938. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 36 pendle crescent the wells road nottingham nottinghamshire t/n NT262940. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 34 pendle crescent the wells road nottingham nottinghamshire t/n NT262941. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 38 pendle crescent the wells road nottingham nottinghamshire t/n NT262939. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 44 pendle crescent the wells road nottingham nottinghamshire t/n NT262936. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1990
    Geliefert am 14. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 76 no 34 pandle crescent, the wells road nottingham together with all buildings and fixtures thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment. By way of assignment the goodwill of the business (if any).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1990
    Geliefert am 14. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 77 no 36 pendle crescent, the wells road, nottingham together with all buildings and fixtures thereon floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1990
    Geliefert am 14. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 78 no 38 pendle crescent, the wells rd nottingham together with all buildings and fixtures thereon floating charge over all moveable plant machinry implements utensils furniture. By way of assignment the goodwill of the business (if any).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1990
    Geliefert am 14. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 79 no 40 pendle crescent, the wells rd nottingham together with all buildings and fixtures thereon floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture goods and equipment. By way of assignment the goodwill of the business (if any).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0