I.E. GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | I.E. GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02542977 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von I.E. GROUP LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich I.E. GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 48 Broadway PE1 1YW Peterborough Cambridgeshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von I.E. GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SEC GROUP PLC | 29. März 1999 | 29. März 1999 |
| SECURITISED ENDOWMENT CONTRACTS PLC | 22. Nov. 1990 | 22. Nov. 1990 |
| REALBOND PLC | 25. Sept. 1990 | 25. Sept. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von I.E. GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für I.E. GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für I.E. GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2011 bis 31. März 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr. Michael Alastair Couzens am 05. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Hooper als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Couzens als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Marie Fiona Fisher als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diana Monger als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA* am 20. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 4 Seiten | MISC | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Wadelin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Hooper als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Diana Monger als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von I.E. GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER, Marie Fiona | Geschäftsführer | Broadway PE1 1YW Peterborough 48 Cambridgeshire | United Kingdom | British | 157495860001 | |||||
| DRAIN, Antony Peter | Sekretär | 10 Eglington Road E4 7AN London | British | 60698090001 | ||||||
| ELLIS, Robert Gordon | Sekretär | Severals Oakwood PO18 9AL Chichester West Sussex | British | 33165610001 | ||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||
| MONGER, Diana | Sekretär | Verdley Place Fernhurst GU27 3ER Haslemere Oefield House Surrey | 148091340001 | |||||||
| PINNICK, Jeffrey | Sekretär | 34 Barnet Gate Lane EN5 2AB Barnet Hertfordshire | British | 8659220002 | ||||||
| RENNIE, Kim Michelle | Sekretär | 58 Oxhey Avenue WD1 4HA Watford Hertfordshire | British | 65899240002 | ||||||
| TRUEMAN, Paul Roland | Sekretär | 71 Park Road CM14 4TU Brentwood Essex | British | 9145660001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||
| WILKINSON, Alan Steven | Sekretär | 11 Copthall Drive NW7 2ND London | British | 61982590001 | ||||||
| S F (FINANCIAL AND MANAGEMENT) SERVICES LIMITED | Sekretär | 23-25 Eastcastle Street W1N 8AE London | 16340140001 | |||||||
| ANSELL, Nicholas Paul | Geschäftsführer | Hetlee Farm Leigh Road SK9 6DS Wilmslow Cheshire | England | British | 48033090001 | |||||
| ATTWOOD, Thomas Roger | Geschäftsführer | Manor House Gills Green TN18 5AE Cranbrook Hawkshurst Kent | United Kingdom | British | 50051050001 | |||||
| BARNARD, Nigel Parry | Geschäftsführer | 19 Roehampton Court Queens Ride Barnes SW13 0HU London | Denmark | British | 48030310001 | |||||
| COLLINS, Adrian John Reginald | Geschäftsführer | 4 Campden Hill Square W8 7LB London | England | British | 465730003 | |||||
| COUZENS, Michael Alastair | Geschäftsführer | Nell Hill Hannington SN6 7RU Wilstshire Nell House England England | United Kingdom | British | 75553130006 | |||||
| DRAIN, Antony Peter | Geschäftsführer | 10 Eglington Road E4 7AN London | United Kingdom | British | 60698090001 | |||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||
| GREENWOOD, Timothy Sandiford | Geschäftsführer | Herons Brook Chelford Road Prestbury SK10 4AW Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 101284380001 | |||||
| HOOPER, Paul | Geschäftsführer | London Road Charlton Kings GL52 6UY Cheltenham Little Shipton Gloucester United Kingdom | United Kingdom | British | 152500600001 | |||||
| KALISH, Geoffrey | Geschäftsführer | 780 Third Avenue Ninth Floor Newyork Usa | American | 64379780001 | ||||||
| KLUG, Bernard Philip | Geschäftsführer | 57 Sheldon Avenue N6 4NH London | British | 15387060001 | ||||||
| MARTIN, Ivan | Geschäftsführer | 90 Ranelagh Road Ealing W5 5RP London | England | British | 123233030001 | |||||
| PINNICK, Jeffrey | Geschäftsführer | 34 Barnet Gate Lane EN5 2AB Barnet Hertfordshire | England | British | 8659220002 | |||||
| RADCLIFFE, Mark Hugh Joseph | Geschäftsführer | The Malt House Upton, Nr Andover SP11 0JS Andover Hampshire | British | 33402910003 | ||||||
| ROBSON, Rupert Hugo Wynne | Geschäftsführer | 2 Carlyle Mansions Cheyne Walk SW3 5LS London | British | 9727390002 | ||||||
| ROSENZWEIG, Max | Geschäftsführer | 7 Williams Way WD7 7EZ Radlett Hertfordshire | British | 74961040001 | ||||||
| TRUEMAN, Paul Roland | Geschäftsführer | 71 Park Road CM14 4TU Brentwood Essex | United Kingdom | British | 9145660001 | |||||
| WADELIN, Mark Thomas | Geschäftsführer | 26 Kings Coughton Lane Kings Coughton B49 5QE Alcester Warwickshire | England | British | 70575020005 | |||||
| WADELIN, Mark Thomas | Geschäftsführer | 26 Kings Coughton Lane Kings Coughton B49 5QE Alcester Warwickshire | England | British | 70575020005 | |||||
| WEBSTER, John Dudley | Geschäftsführer | 10 Merrydown Way BR7 5RS Chislehurst Kent | British | 457110001 | ||||||
| WILKINSON, Alan Steven | Geschäftsführer | 11 Copthall Drive NW7 2ND London | British | 61982590001 | ||||||
| MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Burleigh House Chapel Oak Salford Priors WR11 8SP Evesham | 82547250002 |
Hat I.E. GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 31. Dez. 1997 Geliefert am 19. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all "deposits" in and to the charged account with barclays bank PLC re;-sec group PLC business premium account no;-00928852. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 1997 Geliefert am 15. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Apr. 1997 Geliefert am 18. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity of even date | |
Kurze Angaben First fixed charge all its right title and interest in respect of:- the account held by the company with the bank at 38 mosley street manchester designated "the royal bank of scotland PLC - cash deposit be sec group PLC to support guarantee liability" under account number 20122924 (or such other replacement (account(s) in which the new deposit is held (the "new account")) and amount from time to time standing to the credit of the account and all rights accruing in respect of the new account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge over cash deposit | Erstellt am 20. Mai 1996 Geliefert am 03. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a counter-indemnity of even date | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in:- the account held by the company with the bank designated "rbs : re- sec group PLC" under account number:20078186 (the "account"). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage and assignment | Erstellt am 28. Nov. 1991 Geliefert am 11. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All policies of insurance and all moneys payable thereunder please see doc M200C for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Sept. 1991 Geliefert am 20. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (For further details see doc 396 tc ref M339C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0