EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02549638 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
627TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED | 18. Okt. 1990 | 18. Okt. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution insolvency:- re. Books & accounts | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Windlebrook House Guildford Road Bagshot Surrey GU19 5NG am 01. März 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b |
Wer sind die Geschäftsführer von EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVELL, David Thomas | Sekretär | 59 Gabriels Square Lower Earley RG6 3WN Reading | British | Accountant | 100714080002 | |||||
LOVELL, David Thomas | Geschäftsführer | 59 Gabriels Square Lower Earley RG6 3WN Reading | England | British | Accountant | 100714080002 | ||||
TAVIANSKY, Leon | Geschäftsführer | 14 Pinehurst SL5 0TN Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 99965810001 | ||||
BRUCE, Charles Alexander | Sekretär | 8 Prior Croft Close GU15 5DE Camberley Surrey | British | Director | 3767870002 | |||||
HANNA, Roisin | Sekretär | 180 Holywell Upper Kilmacud Road Dublin 14 Dublin Ireland | British | 44105690001 | ||||||
ALLEN, Eamon Joseph | Geschäftsführer | Grenagh Avoca Avenue Blackrock County Dublin Ireland | Irish | Director | 33780080001 | |||||
BRUCE, Charles Alexander | Geschäftsführer | 8 Prior Croft Close GU15 5DE Camberley Surrey | British | Director | 3767870002 | |||||
FEY, Anthony John | Geschäftsführer | Summer Meadow The Green Shamley Green GU5 0UA Guildford Surrey | England | British | Director | 6267430002 | ||||
MANIFOLD, Albert Jude | Geschäftsführer | Spynans House Kiltegan County Wicklow Ireland | Ireland | Irish | Director | 264302310001 | ||||
MARKEY, John | Geschäftsführer | 25 Tollway Sherfield Park Chinham RG24 8RJ Basingstoke Hants | British | Director | 33032500001 | |||||
MCGUIRE, Vivian Francis | Geschäftsführer | 12 Knocknacree Park Dalkey County Dublin Ireland | Irish | Director | 30974070001 | |||||
MONKS, John Andrew | Geschäftsführer | 30 Fairlawn Park Kettlewell Hill GU21 4HT Woking Surrey | United Kingdom | British | Director | 219360003 | ||||
POMFRET, John William | Geschäftsführer | 53a Woodham Park Road Woodham KT15 3TN Addlestone Edgefield Surrey | England | British | Director | 135129630001 | ||||
WAKLEY, Richard Paul | Geschäftsführer | 33 Western Road Hiltingbury SO53 5DG Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | Director | 64172380004 |
Hat EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 26. Aug. 1992 Geliefert am 16. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 26TH august 1992 and the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben See form 395 ref M77. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 30. Nov. 1990 Geliefert am 05. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries, under the terms of the senior facility agreement dated 30.11.90 the mezzaning loan agreement the interest rate hedging agreements and an overdraft facility, and all monies due or to become due from the S.K. fly & son limited to the chargee as trustee for the beneficiaries, under the terms of the senior facility agreement dated 30-11-90, the interest rate hedging agreements and an overdraft facility. | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a riverdene industrial estate, hersham, surrey. Title nos: sy 433369, sy 585271 and sy 548866, and/or the proceeds of sale thereof. Including buildings and fixtures. (See form 395 for full details).. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat EAGLE PRESS HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0