FINTRADE TECHNOLOGIES LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFINTRADE TECHNOLOGIES LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02552592
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    • (2754) /

    Wo befindet sich FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kings Wharf
    20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALLOY WHEELS INTERNATIONAL LIMITED05. Feb. 199105. Feb. 1991
    MISLEX (5) LIMITED26. Okt. 199026. Okt. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2002

    Welche sind die letzten Einreichungen für FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Verschiedenes

    Sec of state's release of liq
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Sec of state's release of liq
    1 SeitenMISC

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    4 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    4 Seiten2.34B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    15 Seiten2.17B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    5 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht

    18 Seiten2.16B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    31 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von FINTRADE TECHNOLOGIES LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARM SECRETARIES LIMITED
    Somers Mounts Hill
    Benenden
    TN17 4ET Cranbrook
    Kent
    Sekretär
    Somers Mounts Hill
    Benenden
    TN17 4ET Cranbrook
    Kent
    60146690007
    VERMAAK, Gerhardus
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    Geschäftsführer
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    South African80269840003
    BELL, Paul Harrison
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    Sekretär
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    British74801170002
    DAVIES, Stephen Raymond
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    Sekretär
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    British50734440001
    DRURY, Kenneth Malcolm
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Sekretär
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    British56761690004
    EVANS, Lyn
    2 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    Sekretär
    2 Dental Close
    Borden
    ME10 1DT Sittingbourne
    Kent
    British66828710002
    HERSCH, Benson Selwyn
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    British6057020001
    LINLEY, Andrew Northam
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    Sekretär
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    South African39628820001
    BELL, Paul Harrison
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Rowan House Stonewall Park Road
    Langton Green
    TN3 0HN Tunbridge Wells
    Kent
    British74801170002
    COOK, Peter George
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Grove Cottages
    Hogg Lane
    WD6 3AL Elstree
    Middlesex
    British36768870001
    DAVIES, Stephen Raymond
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    Geschäftsführer
    15 Court Lodge
    Shorne
    DA12 3EQ Gravesend
    Kent
    EnglandBritish50734440001
    DEELEY, Michael David
    33 Copper Tree Court
    Loose
    ME15 9RW Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    33 Copper Tree Court
    Loose
    ME15 9RW Maidstone
    Kent
    British4904280001
    DRURY, Kenneth Malcolm
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Dairy Farm Cottage
    Sutton Hoo,
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    British56761690004
    DYNE, Ronald Irvin
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    Geschäftsführer
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    British10505810001
    LE ROUX, Allan
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    Geschäftsführer
    13 Mayflower House
    Valetta Way
    ME1 1FA Rochester
    Kent
    South African83399270002
    LINDSAY, Antony Dennis
    26 Jubilee Close
    Cam
    GL11 5JQ Dursley
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    26 Jubilee Close
    Cam
    GL11 5JQ Dursley
    Gloucestershire
    British31476550001
    LINLEY, Andrew Northam
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    9 Briar Fields
    Grove Green
    ME14 5UZ Maidstone
    Kent
    South African39628820001
    MERRITT, Paul Henry
    Green Hedges
    Chambers Green Road Pluckley
    TN27 0RH Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Green Hedges
    Chambers Green Road Pluckley
    TN27 0RH Ashford
    Kent
    British86760460001
    NOAKES, Bernard
    24 Petersfield
    Broomfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    24 Petersfield
    Broomfield
    CM1 4EP Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish20377840002
    SCHLOSBERG, Hilton Hiller
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    South African36217260002
    WALLER, John Daniel Arthur
    Berkeley House Berkeley Road
    TN20 6EH Mayfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Berkeley House Berkeley Road
    TN20 6EH Mayfield
    East Sussex
    British31476590001

    Hat FINTRADE TECHNOLOGIES LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 05. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Account charge
    Erstellt am 06. Apr. 2001
    Geliefert am 18. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities of the company and/or aac to the bank as at the date of the charge or thereafter (as from time to time modified, amended, renewed or extended) under the agreement and/or any security document (including the charge) to which the company and/or aac is a party and all other monies, obligations and liabilities of the company and/or aac to the bank howsoever arising (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    With full title guarantee all its right, title and interest in the account and the deposit as a continuing security in favour of the bank for the discharge of the secured obligations.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2000
    Geliefert am 22. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 17. März 1998
    Geliefert am 18. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 x efco horizontal conveyorised alloy wheel pre-heating oven serial number 45697 together with the proceeds and products thereof benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts in respect of the prope rty. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Industrial Leasing LTD
    • Royscot Commercial Leasing LTD.
    • Royscot Leasing LTD.
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    Transaktionen
    • 18. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Jan. 1997
    Geliefert am 30. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to any beneficiary (as defined) pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted and on any other account whatsoever together with all expenses under the terms of this debenture
    Kurze Angaben
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Group cross-guarantee indemnity and debenture
    Erstellt am 22. Jan. 1997
    Geliefert am 04. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under clause 2 of the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Must Screens Bv
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 1995
    Geliefert am 08. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The plant machinery chattels or other equipment of the company as specified in the attached continuation sheets which also contain details of covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 08. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Apr. 1994
    Geliefert am 05. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The plant machinery chattels or other equipment described in the schedule to the deed together with any alterations accessories replacements and renewals from time to time thereto. The benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation thereto........ See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 05. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juli 1993
    Geliefert am 27. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Meespierson N.V.
    Transaktionen
    • 27. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juli 1993
    Geliefert am 26. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 23. Juli 1993
    Geliefert am 24. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The plant machinery and chattels of the company as detailed on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 24. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property comprising the former parkfield works lying to the east of cardiff road,taff's well,taff-ely mid glamorgan t/n WA405745.
    Berechtigte Personen
    • Allied Trust Bank Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 1993
    Geliefert am 15. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property comprising the mellingriffith works,whitchurch,cardiff,s glamorgan t/n wa 150348.
    Berechtigte Personen
    • Allied Trust Bank Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 1991
    Geliefert am 16. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/1/91 and/or a supplemental loan agreement dated 22/7/91 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of cardiff road, taff's well title no:- wa 405745 together with the entire benefit of all its rights title & inteest in all occupational and/& business leases a tenancies etc. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 1991
    Geliefert am 16. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/1/91 and/or a supplemental loan agreement dated 22/7/91 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at milingriffith works, whitchurch title no:- wa 150348 together with the entire benefit of all its rights title & interest in all occupational and/or business leases a tenancies etc. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures & fittings) (see form 395 for full details and details of the property).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FINTRADE TECHNOLOGIES LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Dez. 2004Ende der Verwaltung
    11. Dez. 2003Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony David Nygate
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    London
    W1u 3ll
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    London
    W1u 3ll
    James Joseph Bannon
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    1
    DatumTyp
    10. Dez. 2004Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    2
    DatumTyp
    05. Aug. 2010Aufgelöst am
    12. Dez. 2005Antragsdatum
    05. Aug. 2008Abschluss der Liquidation
    08. März 2006Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0