PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED

PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02553549
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 291 & 296 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beendigung der Bestellung von Peter Louden als Geschäftsführer am 13. März 2012

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Crestwood House Birches Rise Willenhall West Midlands WV13 2DB am 11. Apr. 2012

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Louden am 07. Dez. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Nov. 2011

    Kapitalaufstellung am 01. Nov. 2011

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Louden am 26. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Bernard Burns als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Peter Louden als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Bernard Kenneth Robbie Burns am 30. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ian David Horsfall am 30. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ian David Horsfall am 30. Nov. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Sekretär
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    BritishFinance Director104565220001
    HORSFALL, Ian David
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    EnglandBritishFinance Director104565220001
    GWILLIAM, Stephen Paul
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    Sekretär
    5 Andover Crescent
    DY6 8PH Kingswinford
    West Midlands
    British93396970001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Sekretär
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishDirector35522270001
    VANVENROOIJ, Douglas John
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    British16106290002
    BLACK, David Russell
    Upper House
    Ashperton
    HR8 2SA Ledbury
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Upper House
    Ashperton
    HR8 2SA Ledbury
    Herefordshire
    BritishDirector2755270003
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector239557120001
    DUNN, Lloyd John Charles
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector105512500001
    JACKSON, Paul
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishDirector40294740001
    KELLY, Robert David Lindsay
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandWelshDirector161123860001
    LOUDEN, Peter
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Unit 291 & 296
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector172376370001
    O'ROURKE, Gerald
    63 Manor Road
    TW15 2SL Ashford
    Middlesex
    Geschäftsführer
    63 Manor Road
    TW15 2SL Ashford
    Middlesex
    EnglandBritishOperations Director66245110003
    POTTER, Ian Roger
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant63766210003
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    ROSSITER, Philip
    Coppathorne Wapsey Lane
    Hedgerley
    SL2 3XG Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Coppathorne Wapsey Lane
    Hedgerley
    SL2 3XG Slough
    Berkshire
    BritishGarage Proprietor12257420001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    BritishDirector35522270001
    SMITH, Martin
    3 The Wilderness
    Molesey Park Road
    KT8 0JT East Molesey
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 The Wilderness
    Molesey Park Road
    KT8 0JT East Molesey
    Surrey
    United KingdomBritishSales Director11712330002
    VANVENROOIJ, Douglas John
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    29 Thomas Drive
    Warfield
    RG12 6DZ Bracknell
    Berkshire
    BritishFinancial Director16106290002

    Hat PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between pacemaker distribution limited and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between pacemaker distribution limited and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Geliefert am 03. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Geliefert am 13. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Aug. 1997
    Geliefert am 27. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1997
    Geliefert am 07. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Book debts debenture
    Erstellt am 16. Nov. 1994
    Geliefert am 18. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Jan. 1993
    Geliefert am 14. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H unit 13 trident way international trading estate brent road southall middlesex.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Nov. 1992
    Geliefert am 10. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PACEMAKER DISTRIBUTION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    06. Mai 2013Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0