OPEN ACCOUNTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOPEN ACCOUNTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02561244
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OPENAGE LIMITED14. Aug. 199114. Aug. 1991
    WORTHFORT LIMITED22. Nov. 199022. Nov. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2015

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Paul David Gibson als Geschäftsführer am 09. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Gordon James Wilson als Direktor am 09. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Vinodka Murria als Geschäftsführer am 18. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Barbara Ann Firth als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Vinodka Murria am 06. Dez. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 259,859
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 26. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 259,859
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2013

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Barbara Ann Firth am 11. Dez. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2012

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul David Gibson am 06. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2011

    7 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Hilary Lowe als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Hilary Anne Lowe als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Gibson als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Mark Harry Thompson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von OPEN ACCOUNTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILSON, Gordon James
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish200853210001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Sekretär
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    JANES, Paul Nicholas
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    British24280810002
    LINCOLN, Jeremy James Passmore
    The Mill House
    West Farndon
    NN11 3TX Daventry
    Northamptonshire
    Sekretär
    The Mill House
    West Farndon
    NN11 3TX Daventry
    Northamptonshire
    British77671560001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Sekretär
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159477980001
    WILLIAMS, Shirley Ann
    Paddocks View
    15 Newland Street
    LE16 8LW Braybrooke
    Mkt Harborough
    Sekretär
    Paddocks View
    15 Newland Street
    LE16 8LW Braybrooke
    Mkt Harborough
    British32807350001
    BRACKEN, Jennifer Mary
    6 Cave Close
    Cawston
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    6 Cave Close
    Cawston
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish64931860003
    BUSHELL, Stephen
    23 Isham Close
    NN2 7AQ Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    23 Isham Close
    NN2 7AQ Northampton
    Northamptonshire
    British64931820001
    COOK, David Anthony
    Brailes Hill House
    Upper Brailes
    OX15 5AT Banbury
    Geschäftsführer
    Brailes Hill House
    Upper Brailes
    OX15 5AT Banbury
    EnglandBritish28576840003
    COULSON, Richard John
    New Farm
    Fawsley
    NN11 3BT Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    New Farm
    Fawsley
    NN11 3BT Daventry
    Northamptonshire
    British18833330001
    DAVIS, James Richard
    Church Farm View
    LE12 Osgathorpe
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Church Farm View
    LE12 Osgathorpe
    Leicestershire
    British60399700001
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish73934790009
    FROST, Davey
    21 Marriotts Road
    Long Buckby
    NN6 7QY Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    21 Marriotts Road
    Long Buckby
    NN6 7QY Northampton
    Northamptonshire
    EnglandEnglish17000570001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish192439290001
    JANES, Paul Nicholas
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish24280810002
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish57998050007
    THOMPSON, Mark Harry
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish161343370001
    WILLIAMS, Shirley Ann
    29 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    29 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    British32807350002

    Hat OPEN ACCOUNTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. März 2007
    Geliefert am 09. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 2004
    Geliefert am 11. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the white house church walk daventry northampton NN11 4BL t/n NN158704. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2004
    Geliefert am 11. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 24. Feb. 1992
    Geliefert am 06. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0