THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD
Überblick
Unternehmensname | THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 02561611 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Nein |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
- Sonstige Betreuungsaktivitäten n.n.g. (87900) / Gesundheits- und Sozialwesen
- Kindertagesbetreuung (88910) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
THE ADVENTURE FARM TRUST | 23. Nov. 1990 | 23. Nov. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 05. Apr. 2026 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 19. Apr. 2026 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 05. Apr. 2025 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2025 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 29 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Adrian Coverdale als Direktor am 23. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Ms Nicola Michelle Graham als Direktor am 20. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Cessation of Jayne Worrall as a person with significant control on 05. Aug. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Michael John Bulcock as a person with significant control on 04. Aug. 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Beendigung der Bestellung von Jayne Worrall als Geschäftsführer am 05. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael John Bulcock als Geschäftsführer am 04. Aug. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Notification of Peter Andrew Collier as a person with significant control on 06. Aug. 2024 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Notification of Catherine Elizabeth Sandland as a person with significant control on 06. Aug. 2024 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Notification of Peter Scotson as a person with significant control on 06. Aug. 2024 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Ernennung von Ms Catherine Elizabeth Sandland als Direktor am 06. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Peter John Hector Scotson als Direktor am 06. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Peter Andrew Collier als Direktor am 06. Aug. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alice Fiona Mcgladrigan als Geschäftsführer am 31. Juli 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Cessation of Alice Fiona Mcgladrigan as a person with significant control on 31. Juli 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 29 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Ian Eccles as a person with significant control on 16. März 2023 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Bulcock am 12. März 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Mr Michael John Bulcock as a person with significant control on 12. März 2023 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 28 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Ian Eccles as a person with significant control on 21. Apr. 2022 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLIER, Peter Andrew | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | England | British | Photographer | 49203880002 | ||||
COVERDALE, Adrian | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 326926000001 | ||||
GRAHAM, Nicola Michelle | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 208392760001 | ||||
SANDLAND, Catherine Elizabeth | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 118050700001 | ||||
SCOTSON, Peter John Hector | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Self Employed | 272968530001 | ||||
BULCOCK, Michael John | Sekretär | 18 Lisson Grove WA15 9AE Hale Cheshire | British | 82115420001 | ||||||
CLEGG, Nigel Stephen | Sekretär | 16 Oakleigh WA16 8QW Knutsford Cheshire | British | 28863860001 | ||||||
MCKINLAY, Andrew John Robert | Sekretär | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | 240914920001 | |||||||
MONTAGUE, Nicholas Peter | Sekretär | 35 Clover Drive Pickmere WA16 0WF Knutsford Cheshire | British | 42171370006 | ||||||
BABINGTON, Anthony Brutus | Geschäftsführer | 60 Derbyshire Road M33 3EE Sale Cheshire | British | Architect | 28863870001 | |||||
BAKER, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | 4 Steadings Rise WA16 0WB Mere Cheshire | England | British | Company Director | 52457510001 | ||||
BERGIN, Roy | Geschäftsführer | Apartment 11 Ellerslie 9 Suffolk Road WA14 4QX Altrincham | British | Company Director | 45745500002 | |||||
BULCOCK, Michael John | Geschäftsführer | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | England | British | Director | 82115420003 | ||||
FAIRHURST, Graham | Geschäftsführer | 18 Dunlin Rise SK10 3QY Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 62319210002 | ||||
FARRINGTON, Paul Raymond | Geschäftsführer | 4 Walton Road Oldfield Brow WA14 4NE Altrincham | England | British | C.E.O. | 55929240004 | ||||
FOUNTAIN, Christopher Simon | Geschäftsführer | 88 Birches Lane Lostock Green CW9 7SN Northwich Cheshire | British | Corporate Manager | 48993590001 | |||||
GRAHAM, Nicola Michelle | Geschäftsführer | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | England | British | Consultant | 208392760001 | ||||
GRUNDY, Timothy | Geschäftsführer | Bothy Cottage Sulhamstead RG7 4BS Reading Berkshire | British | Broadcaster | 30979100006 | |||||
HAM, Gary | Geschäftsführer | 18 South Grove M33 3AU Sale Cheshire | British | Sales | 54110480001 | |||||
JONES, Brian | Geschäftsführer | Gag Aye Farm Hollinsclough SK17 0RJ Buxton Derbyshire | British | Printer | 24902050002 | |||||
KENNEDY, John Thomas | Geschäftsführer | June Corner Hawley Drive Hale Barns WA15 0DP Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 6334820001 | ||||
LAING, Carol Margaret | Geschäftsführer | 9 Silk Hill Cottages SK23 7TA Buxworth Derbyshire | England | British | Marketing Consultant | 179700530001 | ||||
MCCARTHY, Shaun Nicholas | Geschäftsführer | Holiday Inn Crowne Plaza Peter Street M60 2DS Manchester | British | Hotel General Manager | 33855980001 | |||||
MCGLADRIGAN, Alice Fiona | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 289800900001 | ||||
MCKINLAY, Andrew John Robert | Geschäftsführer | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | England | British | Retired | 272372950001 | ||||
MCKNIGHT, David Angus | Geschäftsführer | Earlesdene Green Walk Bowdon WA14 2SL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 8804270011 | ||||
MCLEAN, Bruce | Geschäftsführer | 11 Peter Street CW9 5NB Northwich Cheshire | British | Project Director | 28863900001 | |||||
MIDDLETON, Jonathan Louis | Geschäftsführer | 20 Heatherfield Court SK9 2QE Wilmslow Cheshire | British | Teacher(Trainee Educationalist | 38406190001 | |||||
MONTAGUE, Nicholas Peter | Geschäftsführer | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | England | British | Director | 42171370006 | ||||
MONTAGUE, Nicholas Peter | Geschäftsführer | 35 Clover Drive Pickmere WA16 0WF Knutsford Cheshire | England | British | Director | 42171370006 | ||||
PEARSON, Mark Philip | Geschäftsführer | 72 Willowmead Drive Prestbury SK10 4BU Cheshire | British | Accountant | 71947840002 | |||||
PLOWRIGHT, Katheryn Anita | Geschäftsführer | 2 The Cuppins Cumber Lane SK96GW Wilmslow Cheshire | British | 41658370001 | ||||||
PUGH, Eleanor | Geschäftsführer | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 260844900001 | ||||
ROGERS, Dennis | Geschäftsführer | Brook House Grappenhall Road Stockton Heath WA4 2AX Warrington Cheshire | British | Estate Agent | 86842430001 | |||||
ROUGHTON, Terence William | Geschäftsführer | The White House 169 London Road North Poynton SK12 1BX Macclesfield Cheshire | England | British | Consultant | 97908770001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Peter Andrew Collier | 06. Aug. 2024 | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Ms Catherine Elizabeth Sandland | 06. Aug. 2024 | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Peter John Hector Scotson | 06. Aug. 2024 | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Alice Fiona Mcgladrigan | 01. Dez. 2021 | Reddy Lane WA14 3RE Millington Booth Bank Farm Cheshire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Jayne Worrall | 30. März 2020 | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Eleanor Pugh | 03. Juli 2019 | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Nicholas Peter Montague | 03. Juli 2019 | Pickmere WA16 0WF Knutsford 35 Clover Drive Cheshire United Kingdom | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Ian Eccles | 01. März 2019 | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Michael John Bulcock | 17. Feb. 2017 | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Nicholas Peter Montague | 06. Apr. 2016 | Booth Bank Farm Reddy Lane WA14 3RE Millington Cheshire | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0