KINGSWAY SCOTLAND LIMITED
Überblick
Unternehmensname | KINGSWAY SCOTLAND LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02562244 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KINGSWAY SCOTLAND LIMITED?
- (5244) /
Wo befindet sich KINGSWAY SCOTLAND LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Baker Street London W1M 1DA |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KINGSWAY SCOTLAND LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GRAINMAY DESIGNS LIMITED | 26. Nov. 1990 | 26. Nov. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KINGSWAY SCOTLAND LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis |
Welche sind die letzten Einreichungen für KINGSWAY SCOTLAND LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 1 Seiten | 4.43 | ||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 3 Seiten | COCOMP | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 26. Juni 2008 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 20. Feb. 2008 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 20. Aug. 2008 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Mitteilung über die Änderung eines Verwaltungsbeschlusses | 6 Seiten | 2.20 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators | 3 Seiten | 2.15 |
Wer sind die Geschäftsführer von KINGSWAY SCOTLAND LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASON, Alan | Sekretär | 207 Highlands Road PO15 5PW Fareham Hampshire | British | Director | 12991220001 | |||||
HALIL, Geoffrey Osman | Geschäftsführer | 71 Goodhart Way BR4 0ET West Wickham Kent | British | Director | 37211830001 | |||||
MASON, Alan | Geschäftsführer | 207 Highlands Road PO15 5PW Fareham Hampshire | British | Director | 12991220001 | |||||
O'BRIEN, Denis | Sekretär | 40 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | Accountant | 34718240002 | |||||
WATTS, Erica Joan | Sekretär | 79 Aviemore Way BR3 3RS Beckenham Kent | British | 23715810001 | ||||||
COMPUTERCOUNTS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 14 Station Road CT7 9DQ Birchington Kent | 70597270001 | |||||||
BRIANT, Karl | Geschäftsführer | Peterscroft Stuckton SP6 2HG Fording Bridge Hampshire | British | Retail Management | 55028350001 | |||||
BRIANT, Paul | Geschäftsführer | 6 Chaddersley Wood Road Sandbanks BH14 8LT Poole Dorset | British | Company Director | 98866750001 | |||||
CLARKE, Keith Robert | Geschäftsführer | The Main House Delaware Farm Haver Road TN8 Edenbridge Kent | British | Director Of Companies | 65523340001 | |||||
DOWDALL, Steven John Wilson | Geschäftsführer | 4 The Paddocks Hempstead ME7 3NG Gillingham Kent | British | Furniture Sales Management | 38219000002 | |||||
FERNBACK, Alan Geoffrey | Geschäftsführer | 20 Park Avenue Farnborough Park BR6 8LL Orpington The Tudors Kent | England | British | Director | 38497170001 | ||||
ILLINGWORTH, Ronald Haydon | Geschäftsführer | 12 Holdenhurst Avenue BH7 6RD Bournemouth Dorset | British | Director | 15951280002 | |||||
ILLINGWORTH, Ronald Haydon | Geschäftsführer | 127 Cranleigh Road Southbourne BH6 5JY Bournemouth Dorset | British | Furniture Consultant | 15951280001 | |||||
MASON, Alan | Geschäftsführer | 207 Highlands Road PO15 5PW Fareham Hampshire | British | Furniture Consultant | 12991220001 | |||||
O'BRIEN, Denis | Geschäftsführer | 40 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | Accountant | 34718240002 | |||||
TOBIN, Timothy Stephen | Geschäftsführer | The Old Bakery Main Street Wymondham LE14 2AG Melton Mowbray Leicestershire | British | Director | 57873550001 |
Hat KINGSWAY SCOTLAND LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 15. Juni 1999 Geliefert am 18. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the account with the bank at its portsmouth branch in the name of lloyds bank PLC re;-kingsway scotland limited denominated in sterling designated business call now numbered 2393556 and any account replacing thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Juni 1999 Geliefert am 11. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 16. Feb. 1999 Geliefert am 20. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Kurze Angaben The tenant charges to the landlord its interest in the account and the deposit balance from time to time and all money from time to time withdrawn from the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 27. Nov. 1998 Geliefert am 02. Dez. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 31. Mai 1996 Geliefert am 11. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the obligations of the company contained in a lease dated 17TH november 1995 and in the deed | |
Kurze Angaben The interest of the company in the account and deposit balance maintained pursuant to the deed and all money from time to time withdrawn from the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Dez. 1995 Geliefert am 19. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement made the 12TH december 1995 | |
Kurze Angaben The l/h property k/a basement ground mezzanine and first floor premises and part second floor car park containing the lift motor room andcold water feed tank being part of 49/51 eden street kingston upon thames surrey t/n TGL88598. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 17. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and/or this deed | |
Kurze Angaben Initial deposit and additional deposit totalling £100,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 07. Okt. 1993 Geliefert am 11. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat KINGSWAY SCOTLAND LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Verwaltungsordnung |
| |||||||||||||||||||||
2 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0