ACTIVE SIGNS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameACTIVE SIGNS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02565076
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ACTIVE SIGNS LIMITED?

    • (3663) /

    Wo befindet sich ACTIVE SIGNS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor Phoenix House
    32 West Street
    BN1 2RT Brighton
    East Sussex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACTIVE SIGNS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für ACTIVE SIGNS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2018

    11 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2017

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2016

    10 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Judd House 16 East Street Tonbridge Kent TN9 1HG zum 2nd Floor Phoenix House 32 West Street Brighton East Sussex BN1 2RT am 27. Jan. 2016

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2015

    16 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2014

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2013

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Feb. 2012

    11 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Jan. 2011

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    14 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Aug. 2010

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Feb. 2010

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Aug. 2009

    9 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    31 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    9 Seiten2.16B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    33 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von ACTIVE SIGNS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, Andrew
    62 Princess Margaret Avenue
    CT12 6HX Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    62 Princess Margaret Avenue
    CT12 6HX Ramsgate
    Kent
    British66407910002
    LASTELLA, Michael Octavio
    35 Canterbury Road East
    CT11 0JX Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    35 Canterbury Road East
    CT11 0JX Ramsgate
    Kent
    British125700440001
    ROBINSON, Ian Edward
    2 Way Farmyard
    Way Hill Minster
    CT12 4HS Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Way Farmyard
    Way Hill Minster
    CT12 4HS Ramsgate
    Kent
    United KingdomBritish32259330002
    TAYLOR, Mitchel
    Tudor Lodge
    Cliff Road
    CT7 9LS Birchington
    Kent
    Geschäftsführer
    Tudor Lodge
    Cliff Road
    CT7 9LS Birchington
    Kent
    British27990320005
    HICKSON, Peter John
    5 Winterstoke Way
    CT11 8AG Ramsgate
    Kent
    Sekretär
    5 Winterstoke Way
    CT11 8AG Ramsgate
    Kent
    British46516050002
    TAYLOR, Mitchel
    Rose Cottage Potten Street
    St Nicholas St Wade
    CT7 0QP Birchington
    Kent
    Sekretär
    Rose Cottage Potten Street
    St Nicholas St Wade
    CT7 0QP Birchington
    Kent
    British27990320003
    DAVIES, Andrew
    62 Princess Margaret Avenue
    CT12 6HX Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    62 Princess Margaret Avenue
    CT12 6HX Ramsgate
    Kent
    British66407910002
    HICKSON, Peter John
    5 Winterstoke Way
    CT11 8AG Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    5 Winterstoke Way
    CT11 8AG Ramsgate
    Kent
    United KingdomBritish46516050002
    JONES, Christopher Michael
    98 Crescent Road
    CT11 9RA Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    98 Crescent Road
    CT11 9RA Ramsgate
    Kent
    United KingdomBritish109549720001
    OLIVER, Alan John
    33 Windmill Road
    CT5 4NL Whitstable
    Kent
    Geschäftsführer
    33 Windmill Road
    CT5 4NL Whitstable
    Kent
    British102725030001
    SHARMAN, Philip Kevin
    High Ridge
    Green Lane
    TN6 2DF Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    High Ridge
    Green Lane
    TN6 2DF Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish39993030001
    SPACKMAN, Steven John
    Alma Cottage
    Wych Cross
    RH18 5JN Forest Row
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Alma Cottage
    Wych Cross
    RH18 5JN Forest Row
    East Sussex
    EnglandBritish39906930003
    STANTON, Elizabeth
    12 Minnis Bay Road
    CT7 9SE Birchington
    Kent
    Geschäftsführer
    12 Minnis Bay Road
    CT7 9SE Birchington
    Kent
    British27990330001

    Hat ACTIVE SIGNS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All assets debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2008
    Geliefert am 30. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2006
    Geliefert am 09. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 2006
    Geliefert am 14. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the south of leigh road ramsgate. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 18. Juli 2006
    Geliefert am 29. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Large format digital printer model JV3 2505P s/no B930-04-0601 large format paper printer model hp 1050 s/no SG11T33112 wall saw model super cut 1205 s/no 4387/9-510 for details of further chattels charged please refer to the FORM395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of haine road ramsgate kent t/n K201895. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 2001
    Geliefert am 21. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south side of leigh road ramsgate thanet kent t/n K247370. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. März 1991
    Geliefert am 17. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 06. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ACTIVE SIGNS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Feb. 2009Beginn der Verwaltung
    07. Feb. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Vincent John Green
    Judd House
    16 East Street
    TN9 1HG Tonbridge
    Kent
    Praktiker
    Judd House
    16 East Street
    TN9 1HG Tonbridge
    Kent
    Mark Newman
    Judd House
    16 East Street
    TN9 1HG Tonbridge
    Kent
    Praktiker
    Judd House
    16 East Street
    TN9 1HG Tonbridge
    Kent
    2
    DatumTyp
    07. Feb. 2011Beginn der Liquidation
    19. Sept. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher David Stevens
    Frp Advisory Llp 4th Floor Southfield House
    11 Liverpool Garders
    BN11 1RY Worthing
    West Sussex
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 4th Floor Southfield House
    11 Liverpool Garders
    BN11 1RY Worthing
    West Sussex
    Colin Ian Vickers
    4th Floor Southfield House 11 Liverpool Gardens
    BN11 1RY Worthing
    Praktiker
    4th Floor Southfield House 11 Liverpool Gardens
    BN11 1RY Worthing

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0