GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED

GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02569263
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Thrid Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    16 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Newton House Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 0WZ zum Thrid Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN am 09. Juli 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 22. Juni 2015

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 658,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Spencer Neal Dredge als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Charles Weaver als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Charles Weaver als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Spencer Neal Dredge als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Haywood Chapman als Direktor am 01. Dez. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Spencer Neal Dredge als Direktor am 31. Jan. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter John Hallett als Geschäftsführer am 31. Jan. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 13. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 658,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    7 SeitenAA

    Ernennung von Mr Paul Harvey Myhill als Sekretär am 01. Jan. 2013

    1 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MYHILL, Paul Harvey
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    Sekretär
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    175307330001
    CHAPMAN, Haywood Trefor
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    Geschäftsführer
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Thrid Floor
    Surrey
    United KingdomBritish193406100001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Sekretär
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    British82233550001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Sekretär
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164940450001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    HOUSTON, Donald John
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Sekretär
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    British45207780002
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    149437450001
    PARISH, Antony Jonathan
    Three Beeches
    139 Old Woking Road
    GU22 8PD Pyrford
    Surrey
    Sekretär
    Three Beeches
    139 Old Woking Road
    GU22 8PD Pyrford
    Surrey
    English21589960002
    PARISH, Deborah
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Sekretär
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    British103332870001
    SIEBERT, Paul William
    56 Rucklidge Avenue
    NW10 4PS London
    Sekretär
    56 Rucklidge Avenue
    NW10 4PS London
    British91575150001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Sekretär
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    CALDER, Ian William
    13 Boscombe Road
    SW19 3AX London
    Geschäftsführer
    13 Boscombe Road
    SW19 3AX London
    British65078310001
    COLEMAN, Nevil David
    51b Englands Lane
    NW3 4YD London
    Geschäftsführer
    51b Englands Lane
    NW3 4YD London
    British67334160001
    CONOLEY, John Richard
    Dromkeen
    Old Compton Lane
    GU9 8EH Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dromkeen
    Old Compton Lane
    GU9 8EH Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish80922910001
    CROSS, Ray John
    52 Waterhouse Moor
    CM18 6BB Harlow
    Essex
    Geschäftsführer
    52 Waterhouse Moor
    CM18 6BB Harlow
    Essex
    British42422430004
    DREDGE, Spencer Neal
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Geschäftsführer
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United KingdomBritish138270950001
    EDWARDS, Roger Francis
    146 Chertsey Lane
    TW18 3LS Staines
    Middlesex
    Geschäftsführer
    146 Chertsey Lane
    TW18 3LS Staines
    Middlesex
    British3398820001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HOUSTON, Donald John
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Geschäftsführer
    10 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    ScotlandBritish45207780002
    JOHN, Ian Clive
    Tynwald
    23a Longfield Drive
    HP6 5HD Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Tynwald
    23a Longfield Drive
    HP6 5HD Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish114024160001
    PARISH, Antony Jonathan
    Winding Wood Eagle Lodge
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Winding Wood Eagle Lodge
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Surrey
    United KingdomBritish21589960003
    PARISH, Deborah
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Geschäftsführer
    Winding Wood,
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    British103332870001
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish100207880001
    RAMZAN, Mohammed
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    British45096260001
    ROWETT, Geoffrey David
    Flat 20 Belvedere House
    Churchfields Avenue
    KT13 9XY Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Flat 20 Belvedere House
    Churchfields Avenue
    KT13 9XY Weybridge
    Surrey
    British58991930003
    STEVENS, Kevin
    42 Armadale Road
    GU21 3LB Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    42 Armadale Road
    GU21 3LB Woking
    Surrey
    British65078350001
    WEAVER, Anthony Charles
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish42686850001

    Hat GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Group debenture
    Erstellt am 21. Juni 2012
    Geliefert am 29. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2005
    Geliefert am 06. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession to a debenture dated 14 may 2001
    Erstellt am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 30. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the obligors (including the company) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 23. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £73,800 plus vat of £12,915;interest bearing account designated "third floor 12/12A golden square london W1 deposit account" the amount sanding from time to time to the credit of such account and all interest credited.
    Berechtigte Personen
    • Carlton Screen Advertising Limited
    Transaktionen
    • 23. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent security deposit deed
    Erstellt am 25. Feb. 2002
    Geliefert am 12. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £12,730 and all other monies credited from time to time to the interest bearing account opened at the london clearing bank where the deposit account is from time to time held by seagate distribution (UK) limited (the "landlord") in the landlords name.
    Berechtigte Personen
    • Seagate Distribution (UK) Limited
    Transaktionen
    • 12. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent security deposit deed
    Erstellt am 25. Feb. 2002
    Geliefert am 06. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £12,730 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit sum of £12,730 plus value added tax together with interest representing security for the performance by the company of its obligations under the lease.
    Berechtigte Personen
    • Seagate Distribution (UK) Limited
    Transaktionen
    • 06. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture deed
    Erstellt am 19. Dez. 1997
    Geliefert am 22. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. März 1996
    Geliefert am 21. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 16. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of rent deposit
    Erstellt am 06. Okt. 1993
    Geliefert am 14. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 06/10/93
    Kurze Angaben
    A reent deposit in the sum of £6453 under the rent deposit.
    Berechtigte Personen
    • Wereldhave Property Corporation PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Juni 2015Beginn der Liquidation
    03. Nov. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Praktiker
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Terence Guy Jackson
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Praktiker
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0