GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02569263 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Thrid Floor One London Square Cross Lanes GU1 1UN Guildford Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Newton House Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 0WZ zum Thrid Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Spencer Neal Dredge als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Charles Weaver als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Charles Weaver als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Spencer Neal Dredge als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Haywood Chapman als Direktor am 01. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Spencer Neal Dredge als Direktor am 31. Jan. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter John Hallett als Geschäftsführer am 31. Jan. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Harvey Myhill als Sekretär am 01. Jan. 2013 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYHILL, Paul Harvey | Sekretär | One London Square Cross Lanes GU1 1UN Guildford Thrid Floor Surrey | 175307330001 | |||||||
| CHAPMAN, Haywood Trefor | Geschäftsführer | One London Square Cross Lanes GU1 1UN Guildford Thrid Floor Surrey | United Kingdom | British | 193406100001 | |||||
| BALAAM, Martin Anthony | Sekretär | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | British | 82233550001 | ||||||
| HAYES, Peter Andrew | Sekretär | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 164940450001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Sekretär | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| HOUSTON, Donald John | Sekretär | 10 Lauder Crescent PH1 1SU Perth | British | 45207780002 | ||||||
| O'RORKE, Nicholas | Sekretär | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | 149437450001 | |||||||
| PARISH, Antony Jonathan | Sekretär | Three Beeches 139 Old Woking Road GU22 8PD Pyrford Surrey | English | 21589960002 | ||||||
| PARISH, Deborah | Sekretär | Winding Wood, Mile Path GU22 0JX Woking | British | 103332870001 | ||||||
| SIEBERT, Paul William | Sekretär | 56 Rucklidge Avenue NW10 4PS London | British | 91575150001 | ||||||
| VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr. | Sekretär | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 80721980001 | ||||||
| BALAAM, Martin Anthony | Geschäftsführer | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| CALDER, Ian William | Geschäftsführer | 13 Boscombe Road SW19 3AX London | British | 65078310001 | ||||||
| COLEMAN, Nevil David | Geschäftsführer | 51b Englands Lane NW3 4YD London | British | 67334160001 | ||||||
| CONOLEY, John Richard | Geschäftsführer | Dromkeen Old Compton Lane GU9 8EH Farnham Surrey | United Kingdom | British | 80922910001 | |||||
| CROSS, Ray John | Geschäftsführer | 52 Waterhouse Moor CM18 6BB Harlow Essex | British | 42422430004 | ||||||
| DREDGE, Spencer Neal | Geschäftsführer | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House | United Kingdom | British | 138270950001 | |||||
| EDWARDS, Roger Francis | Geschäftsführer | 146 Chertsey Lane TW18 3LS Staines Middlesex | British | 3398820001 | ||||||
| HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HOUSTON, Donald John | Geschäftsführer | 10 Lauder Crescent PH1 1SU Perth | Scotland | British | 45207780002 | |||||
| JOHN, Ian Clive | Geschäftsführer | Tynwald 23a Longfield Drive HP6 5HD Amersham Buckinghamshire | England | British | 114024160001 | |||||
| PARISH, Antony Jonathan | Geschäftsführer | Winding Wood Eagle Lodge Mile Path GU22 0JX Woking Surrey | United Kingdom | British | 21589960003 | |||||
| PARISH, Deborah | Geschäftsführer | Winding Wood, Mile Path GU22 0JX Woking | British | 103332870001 | ||||||
| PERKS, Timothy Howard | Geschäftsführer | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 100207880001 | |||||
| RAMZAN, Mohammed | Geschäftsführer | 336 Olton Boulevard West B11 3HJ Birmingham West Midlands | British | 45096260001 | ||||||
| ROWETT, Geoffrey David | Geschäftsführer | Flat 20 Belvedere House Churchfields Avenue KT13 9XY Weybridge Surrey | British | 58991930003 | ||||||
| STEVENS, Kevin | Geschäftsführer | 42 Armadale Road GU21 3LB Woking Surrey | British | 65078350001 | ||||||
| WEAVER, Anthony Charles | Geschäftsführer | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 153397180001 | |||||
| YAPP, Stephen | Geschäftsführer | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | England | British | 42686850001 |
Hat GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Erstellt am 21. Juni 2012 Geliefert am 29. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Okt. 2006 Geliefert am 13. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Nov. 2005 Geliefert am 06. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture dated 14 may 2001 | Erstellt am 30. Apr. 2004 Geliefert am 30. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the obligors (including the company) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 11. März 2004 Geliefert am 23. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £73,800 plus vat of £12,915;interest bearing account designated "third floor 12/12A golden square london W1 deposit account" the amount sanding from time to time to the credit of such account and all interest credited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent security deposit deed | Erstellt am 25. Feb. 2002 Geliefert am 12. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £12,730 and all other monies credited from time to time to the interest bearing account opened at the london clearing bank where the deposit account is from time to time held by seagate distribution (UK) limited (the "landlord") in the landlords name. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent security deposit deed | Erstellt am 25. Feb. 2002 Geliefert am 06. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £12,730 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit sum of £12,730 plus value added tax together with interest representing security for the performance by the company of its obligations under the lease. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture deed | Erstellt am 19. Dez. 1997 Geliefert am 22. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. März 1996 Geliefert am 21. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rent deposit | Erstellt am 06. Okt. 1993 Geliefert am 14. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 06/10/93 | |
Kurze Angaben A reent deposit in the sum of £6453 under the rent deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GENESIS TELECOMMUNICATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0