IMAGO 2014 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | IMAGO 2014 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02575558 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IMAGO 2014 LIMITED?
- Großhandel mit elektronischen und Telekommunikationsgeräten und -teilen (46520) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich IMAGO 2014 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Odyssey Westridge Highclere RG20 9PX Newbury England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IMAGO 2014 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IMAGO 2014 PLC | 19. Sept. 2014 | 19. Sept. 2014 |
| IMAGO GROUP PLC | 05. März 2004 | 05. März 2004 |
| IMAGO MICRO LIMITED | 10. Juli 1991 | 10. Juli 1991 |
| DIPLEMA 245 LIMITED | 21. Jan. 1991 | 21. Jan. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IMAGO 2014 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2020 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2021 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für IMAGO 2014 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Jan. 2020 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Feb. 2020 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Jan. 2019 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für IMAGO 2014 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Kay Vickerage am 12. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom "Genesis" Snelsmore Common Newbury RG14 3BG England zum Odyssey Westridge Highclere Newbury RG20 9PX am 12. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kay Vickerage als Direktor am 01. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Juli 2014 bis 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma und die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT11 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 44 Seiten | MAR | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | RR02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IMAGO 2014 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICKERAGE, Kay | Sekretär | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | British | 12466950002 | ||||||
| GEORGE, Andrew | Geschäftsführer | 54 Wentworth Gardens GU34 2BJ Alton Hampshire | England | British | 115104730001 | |||||
| VICKERAGE, Ian Geoffrey | Geschäftsführer | Snelsmore Common RG14 3BG Newbury "Genesis" Berkshire England | England | British | 24979700003 | |||||
| VICKERAGE, Kay | Geschäftsführer | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | England | British | 207223290001 | |||||
| WEBSTER, Martin | Bevollmächtigter Sekretär | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
| JONES, Kevin Gareth Brown | Geschäftsführer | 52 Cartmel Drive Woodley RG5 3NG Reading | British | 62807710002 | ||||||
| REARDON, Jonathan Andrew | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Westfield Latchmore Bank Little Hallingbury CM22 7PH Bishop's Stortford Hertfordshire | British | 900005030001 | ||||||
| WEBSTER, Martin | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
| WRIGHT, Andrew John | Geschäftsführer | Acre Edge Longton By Passage, Walmer Bridge PR4 5RE Preston Lancashire | England | British | 70446280001 | |||||
| ZABOURA, Margaret | Geschäftsführer | 15 Whiteknights Road RG6 7BY Reading Berkshire | British | 60020330001 | ||||||
| ZARAIAH, Ralph | Geschäftsführer | 31 Sycamore Close Garston WD2 6DF Watford Hertfordshire | British | 45893470001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei IMAGO 2014 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Ian Geoffrey Vickerage | 14. Apr. 2016 | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mrs Kay Vickerage | 14. Apr. 2016 | Westridge Highclere RG20 9PX Newbury Odyssey England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat IMAGO 2014 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Erstellt am 31. Jan. 2012 Geliefert am 02. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 2004 Geliefert am 28. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 02. Okt. 2003 Geliefert am 18. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Juli 2003 Geliefert am 19. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 21. Nov. 2000 Geliefert am 30. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The account with the bank denominated in sterlimg designated lloyds tsb PLC re imago micro limited and now numbered 7559424, all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 02. Okt. 2000 Geliefert am 04. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 28 september 2000 (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed charge upon all book and other debts present and future and all things in action, floating charge the stock in trade and the whole of the charged assets described above. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 11. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date | |
Kurze Angaben All the companys right title benefit and interest in and to the account in which the deposit of £11,940.35 is held together with a sum equivalent to vat thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 09. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 2 december 1999 | |
Kurze Angaben £11,940 due or to become due from the company to the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge by way of debenture | Erstellt am 10. Feb. 1998 Geliefert am 14. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Apr. 1994 Geliefert am 11. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts and other debts other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such charge. Floating charge on all book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 17. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Aug. 1991 Geliefert am 15. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0