W H REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameW H REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02578045
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von W H REALISATIONS LIMITED?

    • (4544) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich W H REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Dte House
    Hollins Mount
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von W H REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WEATHERSEAL HOLDINGS LTD.03. Feb. 199203. Feb. 1992
    GLASNOST HOLDINGS LIMITED30. Jan. 199130. Jan. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von W H REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für W H REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Apr. 2010

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Apr. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Okt. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Okt. 2008

    5 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    10 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    9 Seiten2.34B

    Vermögensübersicht

    50 Seiten2.16B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    7 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    37 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    9 SeitenMA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed weatherseal holdings LTD.\certificate issued on 12/09/06
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2004

    19 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Guarantee approved 21/10/05
    RES13

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    9 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von W H REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EDWARDS, John Savage
    31 Southlands Road
    Goostrey
    CW4 8JF Crewe
    Cheshire
    Sekretär
    31 Southlands Road
    Goostrey
    CW4 8JF Crewe
    Cheshire
    BritishBanker28595490001
    BLACKHURST, Ian Peter
    Quince Cottage
    Brick Lane Allostock
    WA19 9LZ Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Quince Cottage
    Brick Lane Allostock
    WA19 9LZ Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishEngineer44379990008
    DEL MANSO, Martin
    65 Station Road
    Goostrey
    CW4 8PJ Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    65 Station Road
    Goostrey
    CW4 8PJ Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishLegal Administrator27665690001
    EDWARDS, John Savage
    31 Southlands Road
    Goostrey
    CW4 8JF Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    31 Southlands Road
    Goostrey
    CW4 8JF Crewe
    Cheshire
    BritishBanker28595490001
    KENNEDY, Shaun Patrick
    The Meadows Dog Lane
    Newcastle Road North Brereton
    CW11 1RR Sandbach
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Meadows Dog Lane
    Newcastle Road North Brereton
    CW11 1RR Sandbach
    Cheshire
    BritishSales Director77081480002
    KIRK, Adrian Christopher
    8 Mardale Avenue
    Flixton
    M41 5SA Manchester
    Geschäftsführer
    8 Mardale Avenue
    Flixton
    M41 5SA Manchester
    EnglandBritishChartered Accountant93313700001
    PHILLIPS, David John
    3 Westfield Road
    Fernhill Heath
    WR3 7XE Worcester
    Worcestershire
    Sekretär
    3 Westfield Road
    Fernhill Heath
    WR3 7XE Worcester
    Worcestershire
    British73752480001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CASEMENT, Barry
    The Old Rib Farm
    Half Penny Lane
    PR3 2EA Longridge
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Old Rib Farm
    Half Penny Lane
    PR3 2EA Longridge
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director125379890001
    CREWDSON, Michael Paul
    38 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    38 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    BritishDirector56597950001
    DAVIES, John Stuart
    43a Mere Avenue
    CH63 0NE Raby Mere
    Wirral
    Geschäftsführer
    43a Mere Avenue
    CH63 0NE Raby Mere
    Wirral
    BritishAccountant144191330001
    DAVIES, John Stuart
    43a Mere Avenue
    CH63 0NE Raby Mere
    Wirral
    Geschäftsführer
    43a Mere Avenue
    CH63 0NE Raby Mere
    Wirral
    BritishFinancial Director144191330001
    EADY, Roy Thomas
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    EnglandBritishCompany Director3078230001
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    BritishManaging Director53010640001
    KENNEDY, Brian George
    Swettenham Hall
    Swettenham
    CW12 2JZ Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Swettenham Hall
    Swettenham
    CW12 2JZ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director4067600009
    KIRK, Adrian Christopher
    8 Mardale Avenue
    Flixton
    M41 5SA Manchester
    Geschäftsführer
    8 Mardale Avenue
    Flixton
    M41 5SA Manchester
    EnglandBritishChartered Accountant93313700001
    MIDDLEWEEK, John Arthur
    1 Ironbridge Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7DD Cheshire
    Geschäftsführer
    1 Ironbridge Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7DD Cheshire
    BritishCo Director79441930001
    MILES, James Bramwell Douglas
    4 Sandbach Road
    Rode Heath
    ST7 3RN Stoke On Trent
    Cheshire
    Geschäftsführer
    4 Sandbach Road
    Rode Heath
    ST7 3RN Stoke On Trent
    Cheshire
    BritishCompany Director98393000001
    PHILLIPS, David John
    3 Westfield Road
    Fernhill Heath
    WR3 7XE Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    3 Westfield Road
    Fernhill Heath
    WR3 7XE Worcester
    Worcestershire
    BritishAccountant73752480001
    ROWBOTHAM, Barry Terence
    4 Beltony Drive
    CW1 4TX Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    4 Beltony Drive
    CW1 4TX Crewe
    Cheshire
    BritishMechanical Engineer87702140001
    SPEAKMAN, Eric
    52 Havenwood Road
    WN1 2PA Whitley
    Wigan
    Geschäftsführer
    52 Havenwood Road
    WN1 2PA Whitley
    Wigan
    BritishInstallations Director6945130002
    TAYLOR, William Duncan
    Rushmere Lodge
    Beauty Bank
    CW8 2BP Northwich
    Geschäftsführer
    Rushmere Lodge
    Beauty Bank
    CW8 2BP Northwich
    EnglandBritishCompany Director111733470001
    TAYLOR, William Duncan
    Rushmere Lodge
    Beauty Bank
    CW8 2BP Northwich
    Geschäftsführer
    Rushmere Lodge
    Beauty Bank
    CW8 2BP Northwich
    EnglandBritishSales Director111733470001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat W H REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder
    Kurze Angaben
    F/H unit 2B the phoenix centre road one winsford industrial estate winsford cheshire t/n-CH332145 the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a epson building road one winsford industrial estate winsford cheshire t/n-CH396976 the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the facility documents (as defined) or the protection, preservation or enforcement of the respective rights of the security beneficiaries (as defined) under any facility document, provided that no obligation or liability shall be included in (I) and (ii) above, to the extent that if it were so included, the charge (or any part of it) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all f/h and l/h property (if any) vested in or charged to the company; by way of first fixed charge all plant machinery computeres vehicles office and other equipment, the benefit of the licences, goodwill and uncalled capital; by way of floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever situated both present and future not effectively charged by way of a first fixed mortgage or charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 31. Okt. 1994
    Geliefert am 04. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease dated 31ST october 1994
    Kurze Angaben
    The lessee's interest in a deposit account opened by the lessor's solicitors at a london clearing bank ("rent deposit account") and all money from time to time withdrawn from the rent deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Central and Residential (Jersey) Limited
    • Samoth Limited
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Juli 1992
    Geliefert am 04. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 1 july 1992.
    Kurze Angaben
    The contents of a deposit account held at the royal bank of scotland containing a rent deposit in the sum of £3,250 pursuant to the terms of the rent deposit details.
    Berechtigte Personen
    • Leo Lewis
    Transaktionen
    • 04. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1992
    Geliefert am 06. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £350,000
    Kurze Angaben
    Unit 2B road 1 winsford industrial estate winsford cheshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Supaglide Limited
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Jan. 1992
    Geliefert am 21. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 2B the pheonix centre road one winsford industrial estate winsford cheshire t/n ch 332145 floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1991
    Geliefert am 10. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat W H REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Sept. 2006Beginn der Verwaltung
    20. Apr. 2007Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Poxon
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    Praktiker
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    Paul Reeves
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    2
    DatumTyp
    20. Apr. 2007Beginn der Liquidation
    29. Okt. 2010Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Reeves
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Hollins Lane Bury
    Andrew Poxon
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    Praktiker
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0