HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02578107 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED?
- Herstellung von Sportartikeln (32300) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7 Nelson Street SS1 1EH Southend-On-Sea Essex United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Franklin Van Wezel als Geschäftsführer am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Henry Stupp als Geschäftsführer am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2017 bis 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Aviation Way Southend-on-Sea Essex SS2 6GH zum 7 Nelson Street Southend-on-Sea Essex SS1 1EH am 13. Okt. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Henry Stupp als Direktor am 07. Dez. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Franklin Van Wezel als Geschäftsführer am 07. Dez. 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Michael Farr als Sekretär am 07. Dez. 2016 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Edward Franklin Van Wezel am 15. Feb. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Martinus Christiaan Binnendijk am 15. Feb. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINNENDIJK, Martinus Christiaan | Geschäftsführer | Nelson Street SS1 1EH Southend-On-Sea 7 Essex United Kingdom | Netherlands | Dutch | 86344560005 | |||||
| BELL, Donald James | Sekretär | 18 Shalcross Drive Cheshunt EN8 8UX Waltham Cross | British | 66039210001 | ||||||
| COLLINSON, Jeremy | Sekretär | Aviation Way Southend-On-Sea SS2 6GH Essex | 151071200001 | |||||||
| DE HAAFF, Nick | Sekretär | 2 Wainwright Avenue CM77 7LJ Braintree Essex | British | 76683730002 | ||||||
| DOWELL, Simon Julian | Sekretär | 17 Warrior Square Road SS3 9PZ Shoeburyness Essex | British | 115116630001 | ||||||
| FARR, Ian Michael | Sekretär | Aviation Way Southend-On-Sea SS2 6GH Essex | 173353240001 | |||||||
| HAVILL, Brian Wilson | Sekretär | 11 Stile Lane SS6 8JA Rayleigh Essex | British | 56526290001 | ||||||
| KIRBY, Barry | Sekretär | 36 The Drive CM3 6AA Mayland Essex | British | 73007930001 | ||||||
| VAN WEZEL, Edward Franklin | Sekretär | Parsonage Downs CM6 2AT Great Dunmow Clare Cottage Essex | Dutch | 86478830003 | ||||||
| WATSON, Derek Stephen | Sekretär | 2 Pattison Road NW2 2HH London | British | 65278090001 | ||||||
| AQUIS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 73062690001 | |||||||
| BUTLER, Peter Robert | Geschäftsführer | Gifford House 22 Chalklands Howe Green CM2 7TH Chelmsford Essex | British | 34707070001 | ||||||
| DOWELL, Simon Julian | Geschäftsführer | 17 Warrior Square Road SS3 9PZ Shoeburyness Essex | United Kingdom | British | 115116630001 | |||||
| HAVILL, Brian Wilson | Geschäftsführer | 11 Stile Lane SS6 8JA Rayleigh Essex | British | 56526290001 | ||||||
| HRBACEK, Petr | Geschäftsführer | 22 Mcdivitt Walk SS9 5UD Eastwood | Czech | 116447970002 | ||||||
| LAWSON, Peter Howard | Geschäftsführer | 3 Parker Street LA1 3EP Lancaster Lancashire | United Kingdom | British | 77419230001 | |||||
| LEMKUS, Bradley | Geschäftsführer | 13b Wedderburn Road NW3 5QS London | South African | 49560110005 | ||||||
| MACKNESS, Terry | Geschäftsführer | 2230 Christmas Tree Lane Riverbank 95367 California U S A | British | 46107240002 | ||||||
| POSSAMAI, Paul Antony | Geschäftsführer | Noakes House Noakes Lane, Little Waltham CM3 3NG Chelmsford Essex | United Kingdom | Italian | 164568710001 | |||||
| REYNOLDS, Ashley Stuart | Geschäftsführer | 66 Burges Road SS1 3HT Thorpe Bay Essex | England | British | 3784790001 | |||||
| RICHES, David Charles | Geschäftsführer | 11 Alexandra Road SS6 8HT Rayleigh Essex | United Kingdom | British | 35182670002 | |||||
| RINK, Ronald Alexander | Geschäftsführer | 27 Acacia Drive SS1 3JU Thorpe Bay Essex | South African | 50881150001 | ||||||
| SPRINGALL, Keith John | Geschäftsführer | 6 Mizen Close KT11 2RJ Cobham Surrey | British | 67065490001 | ||||||
| STRONGMAN, David Anthony | Geschäftsführer | 26 Tregothan Road SW9 9JX London | British | 71288690001 | ||||||
| STUPP, Henry | Geschäftsführer | Aviation Way SS2 6GH Southend-On-Sea Hi-Tech House Essex United Kingdom | Usa | American | 222608210001 | |||||
| TRIPCONY, Ian Hugh | Geschäftsführer | 62 Great Wheatley Road SS6 7AP Rayleigh Essex | British | 17984490001 | ||||||
| VAN WEZEL, Edward Franklin | Geschäftsführer | Nelson Street SS1 1EH Southend-On-Sea 7 Essex United Kingdom | Netherlands | Dutch | 86478830014 | |||||
| VAN WEZEL, Franklin | Geschäftsführer | Aviation Way Southend-On-Sea SS2 6GH Essex | United Kingdom | Dutch | 9518210001 | |||||
| WATSON, Derek Stephen | Geschäftsführer | 2 Pattison Road NW2 2HH London | United Kingdom | British | 65278090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Tec Sports Plc | 06. Apr. 2016 | Southend-On-Sea SS2 6GH Essex Aviation Way United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HI-TEC SPORTS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 18. Nov. 2011 Geliefert am 25. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Feb. 2011 Geliefert am 12. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 03. März 2009 Geliefert am 11. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re hi-tec sports international limited business premium account account number 03296237. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Nov. 2007 Geliefert am 28. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2001 Geliefert am 18. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Dez. 1994 Geliefert am 29. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Dez. 1991 Geliefert am 13. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 06. Dez. 1991 Geliefert am 12. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 and continuation sheets relevant to this charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0