COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED

COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02579657
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DELOITTE LLP
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MONTAGUE RHODES LIMITED22. März 199122. März 1991
    FLOREPORT LIMITED04. Feb. 199104. Feb. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    22 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    5 SeitenAM16

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    5 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    32 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2017

    30 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    6 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2016

    29 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2016

    29 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2015

    36 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2015

    41 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2014

    41 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2014

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Wer sind die Geschäftsführer von COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STANTON, Andrew John
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Sekretär
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    BritishDirector85663460002
    BARNSDALL, Thomas Edward
    Marslands Farm Church Lane
    Corley
    CV7 8AS Coventry
    Geschäftsführer
    Marslands Farm Church Lane
    Corley
    CV7 8AS Coventry
    United KingdomBritishDirector58085470001
    INNES, Clive Alexander
    Keepers Cottage
    Lower Binton
    CV37 9TE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Keepers Cottage
    Lower Binton
    CV37 9TE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector11962870001
    STANTON, Andrew John
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector85663460002
    TURNER, Stephen Roger
    5 Walsall Road
    B74 4ND Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    5 Walsall Road
    B74 4ND Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector65282970001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    POSTLETHWAITE, Philip
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector20147100001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    KING, Maurice John
    Warwick House
    5 Philips Croft Hazelwood Road
    DE56 4EF Duffield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Warwick House
    5 Philips Croft Hazelwood Road
    DE56 4EF Duffield
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector34418670001
    LLOYD, Samuel George Alan
    13 Harley Court
    Blake Hall Road
    E11 2QG Wanstead
    London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    13 Harley Court
    Blake Hall Road
    E11 2QG Wanstead
    London
    British900001670001
    NELSON, Peter
    14 Tudor Hill
    B73 6BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    14 Tudor Hill
    B73 6BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector101543330002
    POSTLETHWAITE, Philip
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector20147100001

    Hat COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 13. Mai 2008
    Geliefert am 21. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south of ringland lane costessey norfolk fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 27. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land k/a 1-4 copeman road little plumstead t/n NK340526. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Feb. 2002
    Geliefert am 13. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £7.6 million plus all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a land at chetwynd barracks chilwell nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Feb. 2002
    Geliefert am 08. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the clawback schedule of the transfer dated 4TH february 2002
    Kurze Angaben
    Land at chetwynd barracks chilwell nottingham.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Defence
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Feb. 2002
    Geliefert am 08. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £4,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land at chetwynd barracks chilwell nottingham.
    Berechtigte Personen
    • Barratt Homes Limited Bellway Homes Limited and Westbury Homes (Holdings) Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1999
    Geliefert am 10. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Nov. 1993
    Geliefert am 29. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cofton group limited to the chargee pursuant to a facility letter dated 15TH october 1993 and all other monies due or to become due from the company to singer & friedlander limited pursuant to the facility letter and this charge and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part of selly oak industrial estate (units 5, 6, 7, 8 and 9) elliott road birmingham west midlands t/n WM531573 and the proceeds of sale thereof, fixed and floating charge over all the undertaking property and assets present and future including goodwill uncalled buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 1992
    Geliefert am 11. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 5,6,7,8,9 selly oak industrial estate elliott road selly oak birmingham west midlands t/n WM531573.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Nov. 1991
    Geliefert am 05. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company and/or future styles limited to the chargee under the terms of the mortgage
    Kurze Angaben
    Land to the north of merlins brook, preseli, pembrokeshire in the county of dyfed.
    Berechtigte Personen
    • Caparest Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Agreement and mortgage
    Erstellt am 25. Nov. 1991
    Geliefert am 28. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £300,000.00 under an agreement dated 30/09/91 (see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Van Dijk Securities Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Aug. 1991
    Geliefert am 03. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £200,000
    Kurze Angaben
    Units 5,6,7,8 & 9 selly oak ind. Est. Elliott road, selly oak, birmingham title no wm 531573.
    Berechtigte Personen
    • Van Dijk Securities Limited
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 17. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 5-9 selly oak ind. Est. Elliott road selly oak, birmingham together with all buidlings and fixtures (see form 395 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COFTON LAND & PROPERTY (NORWICH) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. März 2009Beginn der Verwaltung
    27. Sept. 2019Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Charles Reid
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Daniel James Mark Smith
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Michael John Magnay
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0