VAN ELLE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VAN ELLE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02590521 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VAN ELLE LIMITED?
- Bau von sonstigen Bauingenieurprojekten n.a. (42990) / Bauwesen
Wo befindet sich VAN ELLE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southwell Lane Industrial Estate Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Nottinghamshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VAN ELLE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VAN ELLE (HOLDINGS) LIMITED | 11. März 1991 | 11. März 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VAN ELLE LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Apr. 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Jan. 2027 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für VAN ELLE LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 11. März 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 25. März 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 11. März 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für VAN ELLE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Christian Bosworth als Geschäftsführer am 27. Feb. 2026 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2025 | 41 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. März 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2024 | 40 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 025905210025 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Lloyd Cutler als Sekretär am 30. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Helen Louise Prendergast als Sekretär am 30. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2023 | 39 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2022 | 40 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 38 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Malcolm O Sullivan als Direktor am 20. Aug. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Timothy Warner als Direktor am 20. Aug. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 025905210022 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 025905210024 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 36 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 8 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 025905210020 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 025905210023 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 025905210021 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 025905210027, erstellt am 01. Okt. 2020 | 41 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VAN ELLE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRENDERGAST, Helen Louise | Sekretär | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | 328808040001 | |||||||
| CAMPBELL, Graeme Robert James | Geschäftsführer | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | England | British,Australian | 267501520001 | |||||
| CUTLER, Mark Lloyd | Geschäftsführer | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | England | British | 185822570001 | |||||
| O SULLIVAN, Malcolm | Geschäftsführer | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | England | Irish | 286493440001 | |||||
| WARNER, David Timothy | Geschäftsführer | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | England | British | 281720440001 | |||||
| CAFFERKEY, Danielle | Sekretär | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | 238733000001 | |||||||
| CUTLER, Mark Lloyd | Sekretär | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | 263947350001 | |||||||
| DAY, Simon | Sekretär | Wood Farmhouse Broomsthorpe Road Helhoughton Fakenham Norfolk | British | 29044810002 | ||||||
| EDWARDS, Michael John | Sekretär | 98 Main Street Netherseal DE12 8DB Derby Derbyshire | British | 92408630001 | ||||||
| ELLIS, Joan Elizabeth | Sekretär | Hay Farm Ashover Hay S45 0HB Chesterfield Derbyshire | British | 10551940001 | ||||||
| GORBOULD, Ian | Sekretär | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | British | 106055990001 | ||||||
| HOLMES, Richard David | Sekretär | 33 Rise End Middleton DE4 4LS Matlock Derbyshire | British | 155518690001 | ||||||
| KEARNS, Suzanne Jane | Sekretär | 95 Bradshaw Way Irchester NN29 7DW Wellingborough Northamptonshire | British | 8393620001 | ||||||
| PEARSON, Paul Michael | Sekretär | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | 248980970001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AIMSON, Mark John | Geschäftsführer | 2 Bath Road SK17 6HH Buxton Derbyshire | British | 76069420001 | ||||||
| ASHCROFT, Doug | Geschäftsführer | 25 Bowling Green Road LE10 1EX Hinckley Leicestershire | British | 116734320001 | ||||||
| BOSWORTH, Christian | Geschäftsführer | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 116734240001 | |||||
| COLLIN, Trevor | Geschäftsführer | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 37188200001 | |||||
| DAY, Simon | Geschäftsführer | Wood Farmhouse Broomsthorpe Road Helhoughton Fakenham Norfolk | British | 29044810002 | ||||||
| EDWARDS, Michael John | Geschäftsführer | 98 Main Street Netherseal DE12 8DB Derby Derbyshire | United Kingdom | British | 92408630001 | |||||
| ELLIS, Joan Elizabeth | Geschäftsführer | Hay Farm Ashover Hay S45 0HB Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | 10551940001 | |||||
| ELLIS, Michael Frank | Geschäftsführer | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 10551950005 | |||||
| ELLIS, Michael Frank | Geschäftsführer | Hay Farm Ashover Hay S45 0HB Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | 10551950001 | |||||
| FENTON, Jonathan | Geschäftsführer | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | England | British | 162804350001 | |||||
| FOWLER, Alison | Geschäftsführer | 47 West Street MK46 5HH Olney Buckinghamshire | British | 35559810002 | ||||||
| GORBOULD, Ian | Geschäftsführer | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | England | British | 106055990001 | |||||
| HANDLEY, Peter Anthony | Geschäftsführer | 41 Bank Top Road Brecks S65 3DY Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 90629310001 | |||||
| HANDLEY, Victor | Geschäftsführer | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 28874240001 | |||||
| HOLMES, Richard David | Geschäftsführer | 33 Rise End Middleton DE4 4LS Matlock Derbyshire | England | British | 155518690001 | |||||
| HUGHES, Michael Patrick | Geschäftsführer | Hilltop Northwood Lane DE4 2HS Matlock Derbyshire | British | 103885320001 | ||||||
| JONES, Paul | Geschäftsführer | 69 Jewsbury Way Thorpe Astley LE3 3RR Leicester Leicestershire | British | 90629090001 | ||||||
| LARGE, Matthew | Geschäftsführer | 11 Calladine Close NG17 1NQ Sutton In Ashfield Nottinghamshire | British | 99948680001 | ||||||
| LINDUP, Thomas Edward | Geschäftsführer | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Nottinghamshire | England | English | 200649610001 | |||||
| MASON, Michael John | Geschäftsführer | Southwell Lane Industrial Estate Summit Close NG17 8GJ Kirkby-In-Ashfield Southwell Lane Industrial Estate Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 109980400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VAN ELLE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Elle Holdings Plc | 01. Mai 2016 | Kirkby Lane Pinxton NG16 6JA Nottingham Van Elle Holding Splc England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0