FCBI LONDON LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FCBI LONDON LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02593718 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FCBI LONDON LIMITED?
- (7440) /
Wo befindet sich FCBI LONDON LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | FISHER PARTNERS Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FCBI LONDON LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
D P & A LTD. | 15. Juni 1995 | 15. Juni 1995 |
AYER D P & A LIMITED | 05. Apr. 1991 | 05. Apr. 1991 |
SPEED 1300 LIMITED | 21. März 1991 | 21. März 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FCBI LONDON LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FCBI LONDON LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 2 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juni 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:replacement of liquidator | 15 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b |
Wer sind die Geschäftsführer von FCBI LONDON LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAN, Louise | Sekretär | 18 Newbury Close DA2 6AQ Dartford Kent | British | 88994320002 | ||||||
HARRY III, William | Geschäftsführer | The Brake House Back Lane CV37 8SF Lower Quinton Warwickshire | England | American | Accountant | 117064700001 | ||||
BILLETT, Paul Stewart | Sekretär | 32 Cromwell Avenue BR2 9AQ Bromley Kent | British | Accountant | 43584230001 | |||||
MUNDAY, Colin Peter | Sekretär | Hops Lyewood Common TN7 4DB Withyham East Sussex | British | 1824030001 | ||||||
O'TOOLE, Anthony | Sekretär | Hooly Cottage Aisby NG32 3NF Grantham Lincolnshire | British | Director Of Advertising | 47723480002 | |||||
PERRY, Philip James Erskine | Sekretär | 15 Burgess Mead OX2 6XP Oxford Oxfordshire | British | 31292620009 | ||||||
WOODWARD, Stephen James | Sekretär | White Ladies 32 West Hill Sanderstead CR2 0SA South Croydon Surrey | British | Marketing Consultant | 15029320001 | |||||
MBC SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000700001 | |||||||
APPI, Anthony Peter John | Geschäftsführer | 31 Waldeck Road Ealing W13 8LY London | British | Marketing Consultant | 42166240002 | |||||
APPI, Anthony Peter John | Geschäftsführer | 29 Egerton Gardens Ealing W13 8HG London | British | Marketing Consultant | 42166240001 | |||||
BILLETT, Paul Stewart | Geschäftsführer | 32 Cromwell Avenue BR2 9AQ Bromley Kent | British | Accountant | 43584230001 | |||||
DOUGLASS, Daniel Robert | Geschäftsführer | 2 Claremont Road St Margarets TW1 2QY Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Director | 42166340004 | ||||
EDWARDS, David Michael | Geschäftsführer | Tower Cottage Rear Of 12 Culvers Avenue SM5 2BS Carshalton Surrey | British | Creative Director | 88695020001 | |||||
FRETWELL, Neil | Geschäftsführer | 18c Elsynge Road SW18 2HN London | British | Marketing Executive | 88024350001 | |||||
HERRICK, Kathryn Louise | Geschäftsführer | 94 Broom Road TW11 9PF Teddington Middlesex | United Kingdom | British | Finance Director | 76110680001 | ||||
LEAGAS, Ronald Peter Ellis | Geschäftsführer | 9 Richmond Avenue Wimbledon Chase SW20 8LA London | British | Company Director | 65916120003 | |||||
LEVINE, Bryan Anthony | Geschäftsführer | 1 Darville Road N16 7PT London | British | Finance Director | 67682400001 | |||||
MAY, David Robert | Geschäftsführer | 23 Second Avenue W3 7RX London | British | Direct Marketing | 71389830001 | |||||
MUNDAY, Colin Peter | Geschäftsführer | Hops Lyewood Common TN7 4DB Withyham East Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 1824030001 | ||||
O'TOOLE, Anthony | Geschäftsführer | North Barn Village Street NG34 0TD Pickworth Lincolnshire | British | Marketing Consultant | 47723480003 | |||||
O'TOOLE, Anthony | Geschäftsführer | Hooly Cottage Aisby NG32 3NF Grantham Lincolnshire | British | Director Of Advertising | 47723480002 | |||||
PERRY, Philip James Erskine | Geschäftsführer | 15 Burgess Mead OX2 6XP Oxford Oxfordshire | British | Chartered Secretary | 31292620009 | |||||
POOLE, David Leonard | Geschäftsführer | 14 Saxon Drive W3 0NR London | British | Marketing Consultant | 80120000001 | |||||
RENNISON, John Robert Alexander | Geschäftsführer | 8 Wandle Road SW17 7DW London | British | Finance Director | 86028290001 | |||||
STEBBINGS, Carolyn Elizabeth | Geschäftsführer | Flat 2 24 Kew Green TW9 3BH Richmond Surrey | British | Marketing Executive | 73490650001 | |||||
STEWART, Andrew Forsyth | Geschäftsführer | Brentford House The Forty OX10 9LH Cholsey Oxfordshire | British | Certified Accountant | 1824080001 | |||||
TAYLOR, Jonathan | Geschäftsführer | 40 Highgate High Street Highgate N6 5JG London | British | Marketing Consultant | 9489410001 | |||||
TURPIN, Samantha Jayne | Geschäftsführer | 14 Meadway Court Meadway NW11 6PN London | United Kingdom | British | Marketing Executive | 73490590001 | ||||
WOODWARD, Stephen James | Geschäftsführer | White Ladies 32 West Hill Sanderstead CR2 0SA South Croydon Surrey | England | British | Marketing Consultancy | 15029320001 | ||||
WRIGHT, Martin Sean | Geschäftsführer | The Old Barn Shoe Lane SO32 1JJ Upham Hampshire | British | Director | 102656060001 | |||||
DAVID POOLE AND ASSOCIATES LIMITED | Geschäftsführer | 14 Saxon Drive W3 0NR London | 5684230001 | |||||||
DAVID POOLE AND ASSOCIATES LIMITED | Geschäftsführer | 14 Saxon Drive W3 0NR London | 5684230001 | |||||||
MAGNETO LIMITED | Geschäftsführer | 31 Waldeck Road Ealing W13 8LY London | 48665010001 | |||||||
MBC NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000690001 | |||||||
TONY O'TOOLE PLANNING LTD | Geschäftsführer | North Barn Village Street Pickworth NG34 0TD Sleaford Lincolnshire | 54605300001 |
Hat FCBI LONDON LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent security deed | Erstellt am 21. März 1995 Geliefert am 22. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Kurze Angaben £11,250. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. März 1995 Geliefert am 22. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £157,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 09. Feb. 1995 Geliefert am 15. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat FCBI LONDON LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0