FIBROWATT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FIBROWATT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02595814 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIBROWATT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FIBROWATT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIBROWATT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIBROWATT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 025958140017 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Octopus Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 15. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sharna Ludlow als Sekretär am 15. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Stephen Latham am 07. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 025958140017, erstellt am 23. Juli 2018 | 54 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 19. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 30. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Stephen Latham als Direktor am 15. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew George Setchell am 20. Feb. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tim James Senior als Geschäftsführer am 06. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT verlegt | 2 Seiten | AD04 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sharna Ludlow am 31. Mai 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Ernennung von Sharna Ludlow als Sekretär am 06. Mai 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Ward als Sekretär am 06. Mai 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach Woodbridge Suffolk IP12 1BL zum 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT am 01. Apr. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIBROWATT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Holborn EC1N 2HT London 33 England England |
| 253893850001 | ||||||||||
| LATHAM, Paul Stephen | Geschäftsführer | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England | United Kingdom | British | 146527710002 | |||||||||
| SETCHELL, Matthew George | Geschäftsführer | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England | England | British | 157021230004 | |||||||||
| WILKINSON, Edwin John | Geschäftsführer | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | England | British | 86926370001 | |||||||||
| BANERJEE, Kamalika Ria | Sekretär | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 239579580001 | |||||||||||
| DAVISON, James Edward | Sekretär | 20a Spratt Hall Road E11 2RQ London | British | 74915120001 | ||||||||||
| FRASER, Archibald Ian Charles | Sekretär | 70 St Dionis Road SW6 4TU London | British | 54887300001 | ||||||||||
| FRASER, Rupert James | Sekretär | 98 Clarendon Drive SW15 1AH London | British | 25747380001 | ||||||||||
| HELPS, Annabelle Penney | Sekretär | 112 Cromwell Tower Barbican EC2Y 8DD London | Australian | 81687520005 | ||||||||||
| LUDLOW, Sharna | Sekretär | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 208085010001 | |||||||||||
| PICTON TURBERVILL, David | Sekretär | 8 Kingswood Rise Four Marks GU34 5BD Alton Hampshire | British | 87719670002 | ||||||||||
| WARD, Karen | Sekretär | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 204126870001 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Central Square South Orchard Street NE1 3XX Newcastle Upon Tyne | 60471940007 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ANTHONY, Paul | Geschäftsführer | Wentworth House St Leonards Hill SL4 4AT Windsor Berkshire | British | 81406540001 | ||||||||||
| APPS, Paul Gordon | Geschäftsführer | 1 Pointers Close Chieveley RG20 8UJ Newbury Berkshire | British | 88199170001 | ||||||||||
| BOVATI, Paolo | Geschäftsführer | Piazza 5 Agostino 5 FOREIGN Milan 20153 Italy | Italian | 74743800001 | ||||||||||
| CHILTON, Malcolm David | Geschäftsführer | 20 Prosper Meadow DY6 8BA Kingswinford West Midlands | United Kingdom | British | 145829100001 | |||||||||
| COLOMBO, Achille | Geschäftsführer | Via Cortivo 41 Castagnola Ticino 6976 Switzerland | Swiss | 85487490001 | ||||||||||
| COLOMBO, Mario Carlo | Geschäftsführer | Via Solferino 23 Brescia Brescia 25122 Italy | Italian | 81675680001 | ||||||||||
| CONSTANT, Richard Ashley Meyricke | Geschäftsführer | Park Lodge Aislaby YO1 1SW Whitby Yorkshire | British | 19600420001 | ||||||||||
| EVERARD, Ian Douglas | Geschäftsführer | 50 Shoreswood BL1 7DD Bolton Lancashire | British | 28193080001 | ||||||||||
| FRASER, Elspeth Jane | Geschäftsführer | 38 Clarendon Road W11 3AD London | British | 11543170001 | ||||||||||
| FRASER, Elspeth Jane | Geschäftsführer | 38 Clarendon Road W11 3AD London | British | 11543170001 | ||||||||||
| FRASER, Perdita Rachel Josephine | Geschäftsführer | 4 Alexander Street W2 5NT London | England | British | 179346590001 | |||||||||
| FRASER, Rupert James | Geschäftsführer | 98 Clarendon Drive SW15 1AH London | England | British | 25747380001 | |||||||||
| FRASER, Simon Joseph | Geschäftsführer | 38 Clarendon Road W11 3AD London | United Kingdom | British | 15057410001 | |||||||||
| GIACOBELLI, Fabrizio | Geschäftsführer | Via Piave 17 Rescaldina 20027 Milano Italia | Italian | 54917260001 | ||||||||||
| GULLIVER, Peter Leslie | Geschäftsführer | 1 Warren Road Woodley RG5 3AP Reading Berkshire | British | 38491630001 | ||||||||||
| GULLIVER, Peter Leslie | Geschäftsführer | 1 Warren Road Woodley RG5 3AP Reading Berkshire | British | 38491630001 | ||||||||||
| HOLDSWORTH, John Clifford | Geschäftsführer | 9 The Grange Shepherds Lane Caversham RG4 7HZ Reading Berkshire | British | 59930780001 | ||||||||||
| HOLT, Nicholas Christopher | Geschäftsführer | 5 High Park Road TW9 4BL Richmond Upon Thames Surrey | British | 10758310002 | ||||||||||
| KAY, Ian Andrew | Geschäftsführer | 17 Jenner Street Seaforth New South Wales 2092 Australia | British | 102259090001 | ||||||||||
| KING, William John | Geschäftsführer | The Old Laundry Little Horwood MK17 0PG Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 74570800001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIBROWATT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Power Resources Limited | 06. Apr. 2016 | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FIBROWATT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 23. Juli 2018 Geliefert am 30. Juli 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 19. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the counterparty to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 07. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 28. Sept. 2000 Geliefert am 06. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re fibrowatt limited business premisum account number 90106941. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 17. Juli 1997 Geliefert am 21. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a share purchase agreement dated 19TH april 1996, as amended by a supplemental agreement dated 12TH august 1996 and by a second supplemental agreement dated 10TH may 1997 | |
Kurze Angaben All the company's property in and right to receive all or any sums of money that may be or become payable to the company under or in consequence of the terms of a commissioning fee agreement dated 14TH august 1996 up to a maximum aggregate amount of 8,000,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over securities | Erstellt am 17. Juni 1997 Geliefert am 19. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 16TH march 1992 or pursuant to the debenture (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben First fixed charge the shares inclusing all dividends interest or other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over securities | Erstellt am 17. Juni 1997 Geliefert am 19. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the facility agreement dated 30TH november 1990 or pursuant to the debenture (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben First fixed charge over the shares together with any substituted securities inclusive of all dividends interest and other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 19. Mai 1997 Geliefert am 04. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on the due date therefor and otherwise in accordance with the terms of the relevant loan agreements (as therein defined) and the deed | |
Kurze Angaben Fixed charge all "securities" being: all shares in the capital of any subsidiary of the company including all dividends benefits property rights etc, floating charge other than the excluded property (as defined on the M395). Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party account charge | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 13. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under the marubeni loan agreement dated 8TH may 1997 | |
Kurze Angaben Fixed charge over the cash collateral, the account and the debt.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 13. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997) | |
Kurze Angaben All right title and interest in shareholding in fibromass limited and fibrowatt thetford limited.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 13. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997) | |
Kurze Angaben All right, title and interest in and to the second portion of the commissioning fee( as defined in the deed, and the commissioning fee contract dated 12 august 1996). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 21. Aug. 1996 Geliefert am 10. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000 | |
Kurze Angaben The deposit referred to in clause 2 (I) of the account charge and any sum or sums (up to a maximum amount of £500,000) which are from time to time deposited in the bank account in the name of fibrowatt with the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 21. Aug. 1996 Geliefert am 10. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000 | |
Kurze Angaben All or any sums of money that may be or become payable to fibrowatt under or in consequence of the terms of the administration services agreement dated 19TH august 1996. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over securities | Erstellt am 12. Aug. 1996 Geliefert am 29. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee in accordance with the provisions of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben The shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 12. Aug. 1996 Geliefert am 27. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities of the company and fibro holdings limited to the chargee under an option agreement dated 12TH august 1996 | |
Kurze Angaben The sum of £1 and any other sum or sums which are from time to time deposited in an account with the bank of scotland under account no.0044010. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of floating charge | Erstellt am 21. Mai 1996 Geliefert am 05. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 21ST may 1996 | |
Kurze Angaben The undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. März 1994 Geliefert am 06. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 28TH march 1994 being that part of the respective liabilities described above which exceeds the principal amount of £500,000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0