FIBROWATT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFIBROWATT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02595814
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FIBROWATT LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich FIBROWATT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    6th Floor 33 Holborn
    EC1N 2HT London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIBROWATT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für FIBROWATT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 025958140017 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Octopus Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 15. Nov. 2018

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Sharna Ludlow als Sekretär am 15. Nov. 2018

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Stephen Latham am 07. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Eintragung der Belastung 025958140017, erstellt am 23. Juli 2018

    54 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 19. Feb. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 30. Okt. 2017

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Paul Stephen Latham als Direktor am 15. Aug. 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew George Setchell am 20. Feb. 2017

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Tim James Senior als Geschäftsführer am 06. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT verlegt

    2 SeitenAD04

    Änderung der Details des Sekretärs für Sharna Ludlow am 31. Mai 2016

    1 SeitenCH03

    Ernennung von Sharna Ludlow als Sekretär am 06. Mai 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Karen Ward als Sekretär am 06. Mai 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 26. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach Woodbridge Suffolk IP12 1BL zum 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT am 01. Apr. 2016

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von FIBROWATT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Sekretär
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer11677818
    253893850001
    LATHAM, Paul Stephen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    Geschäftsführer
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    United KingdomBritish146527710002
    SETCHELL, Matthew George
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    Geschäftsführer
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    EnglandBritish157021230004
    WILKINSON, Edwin John
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish86926370001
    BANERJEE, Kamalika Ria
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Sekretär
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    239579580001
    DAVISON, James Edward
    20a Spratt Hall Road
    E11 2RQ London
    Sekretär
    20a Spratt Hall Road
    E11 2RQ London
    British74915120001
    FRASER, Archibald Ian Charles
    70 St Dionis Road
    SW6 4TU London
    Sekretär
    70 St Dionis Road
    SW6 4TU London
    British54887300001
    FRASER, Rupert James
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    Sekretär
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    British25747380001
    HELPS, Annabelle Penney
    112 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Sekretär
    112 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Australian81687520005
    LUDLOW, Sharna
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Sekretär
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    208085010001
    PICTON TURBERVILL, David
    8 Kingswood Rise
    Four Marks
    GU34 5BD Alton
    Hampshire
    Sekretär
    8 Kingswood Rise
    Four Marks
    GU34 5BD Alton
    Hampshire
    British87719670002
    WARD, Karen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Sekretär
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    204126870001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    EVERSECRETARY LIMITED
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    60471940007
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANTHONY, Paul
    Wentworth House
    St Leonards Hill
    SL4 4AT Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Wentworth House
    St Leonards Hill
    SL4 4AT Windsor
    Berkshire
    British81406540001
    APPS, Paul Gordon
    1 Pointers Close
    Chieveley
    RG20 8UJ Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Pointers Close
    Chieveley
    RG20 8UJ Newbury
    Berkshire
    British88199170001
    BOVATI, Paolo
    Piazza 5 Agostino 5
    FOREIGN Milan
    20153
    Italy
    Geschäftsführer
    Piazza 5 Agostino 5
    FOREIGN Milan
    20153
    Italy
    Italian74743800001
    CHILTON, Malcolm David
    20 Prosper Meadow
    DY6 8BA Kingswinford
    West Midlands
    Geschäftsführer
    20 Prosper Meadow
    DY6 8BA Kingswinford
    West Midlands
    United KingdomBritish145829100001
    COLOMBO, Achille
    Via Cortivo 41
    Castagnola
    Ticino 6976
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Via Cortivo 41
    Castagnola
    Ticino 6976
    Switzerland
    Swiss85487490001
    COLOMBO, Mario Carlo
    Via Solferino
    23 Brescia
    Brescia
    25122
    Italy
    Geschäftsführer
    Via Solferino
    23 Brescia
    Brescia
    25122
    Italy
    Italian81675680001
    CONSTANT, Richard Ashley Meyricke
    Park Lodge
    Aislaby
    YO1 1SW Whitby
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Lodge
    Aislaby
    YO1 1SW Whitby
    Yorkshire
    British19600420001
    EVERARD, Ian Douglas
    50 Shoreswood
    BL1 7DD Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    50 Shoreswood
    BL1 7DD Bolton
    Lancashire
    British28193080001
    FRASER, Elspeth Jane
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Geschäftsführer
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    British11543170001
    FRASER, Elspeth Jane
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Geschäftsführer
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    British11543170001
    FRASER, Perdita Rachel Josephine
    4 Alexander Street
    W2 5NT London
    Geschäftsführer
    4 Alexander Street
    W2 5NT London
    EnglandBritish179346590001
    FRASER, Rupert James
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    Geschäftsführer
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    EnglandBritish25747380001
    FRASER, Simon Joseph
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Geschäftsführer
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    United KingdomBritish15057410001
    GIACOBELLI, Fabrizio
    Via Piave 17
    Rescaldina 20027
    Milano
    Italia
    Geschäftsführer
    Via Piave 17
    Rescaldina 20027
    Milano
    Italia
    Italian54917260001
    GULLIVER, Peter Leslie
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    British38491630001
    GULLIVER, Peter Leslie
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    British38491630001
    HOLDSWORTH, John Clifford
    9 The Grange
    Shepherds Lane Caversham
    RG4 7HZ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 The Grange
    Shepherds Lane Caversham
    RG4 7HZ Reading
    Berkshire
    British59930780001
    HOLT, Nicholas Christopher
    5 High Park Road
    TW9 4BL Richmond Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 High Park Road
    TW9 4BL Richmond Upon Thames
    Surrey
    British10758310002
    KAY, Ian Andrew
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    Geschäftsführer
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    British102259090001
    KING, William John
    The Old Laundry
    Little Horwood
    MK17 0PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Laundry
    Little Horwood
    MK17 0PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish74570800001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIBROWATT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    06. Apr. 2016
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03302734
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat FIBROWATT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Juli 2018
    Geliefert am 30. Juli 2018
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 19. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the counterparty to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • British Gas Trading Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 07. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Europe Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 28. Sept. 2000
    Geliefert am 06. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re fibrowatt limited business premisum account number 90106941. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment
    Erstellt am 17. Juli 1997
    Geliefert am 21. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a share purchase agreement dated 19TH april 1996, as amended by a supplemental agreement dated 12TH august 1996 and by a second supplemental agreement dated 10TH may 1997
    Kurze Angaben
    All the company's property in and right to receive all or any sums of money that may be or become payable to the company under or in consequence of the terms of a commissioning fee agreement dated 14TH august 1996 up to a maximum aggregate amount of 8,000,000.
    Berechtigte Personen
    • Eastern Generation Limited
    Transaktionen
    • 21. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over securities
    Erstellt am 17. Juni 1997
    Geliefert am 19. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 16TH march 1992 or pursuant to the debenture (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    First fixed charge the shares inclusing all dividends interest or other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi,LTD.,
    Transaktionen
    • 19. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over securities
    Erstellt am 17. Juni 1997
    Geliefert am 19. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the facility agreement dated 30TH november 1990 or pursuant to the debenture (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    First fixed charge over the shares together with any substituted securities inclusive of all dividends interest and other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.,
    Transaktionen
    • 19. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Mai 1997
    Geliefert am 04. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on the due date therefor and otherwise in accordance with the terms of the relevant loan agreements (as therein defined) and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed charge all "securities" being: all shares in the capital of any subsidiary of the company including all dividends benefits property rights etc, floating charge other than the excluded property (as defined on the M395). Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Finstahl S.A.
    • Foster Wheeler Energy Limited
    • Societa Nordelettrica S.P.a Sondel(As Agent and Security Trustee for the Lenders (as Therein Defined) or Any of Them
    Transaktionen
    • 04. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party account charge
    Erstellt am 08. Mai 1997
    Geliefert am 13. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under the marubeni loan agreement dated 8TH may 1997
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the cash collateral, the account and the debt.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marubeni UK PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 08. Mai 1997
    Geliefert am 13. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in shareholding in fibromass limited and fibrowatt thetford limited.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marubeni UK PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment
    Erstellt am 08. Mai 1997
    Geliefert am 13. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997)
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in and to the second portion of the commissioning fee( as defined in the deed, and the commissioning fee contract dated 12 august 1996).
    Berechtigte Personen
    • Marubeni UK PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Account charge
    Erstellt am 21. Aug. 1996
    Geliefert am 10. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000
    Kurze Angaben
    The deposit referred to in clause 2 (I) of the account charge and any sum or sums (up to a maximum amount of £500,000) which are from time to time deposited in the bank account in the name of fibrowatt with the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eastern Generation Limited
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 21. Aug. 1996
    Geliefert am 10. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000
    Kurze Angaben
    All or any sums of money that may be or become payable to fibrowatt under or in consequence of the terms of the administration services agreement dated 19TH august 1996. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eastern Generation Limited
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over securities
    Erstellt am 12. Aug. 1996
    Geliefert am 29. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee in accordance with the provisions of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Trustee for Each of Thelenders
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 12. Aug. 1996
    Geliefert am 27. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities of the company and fibro holdings limited to the chargee under an option agreement dated 12TH august 1996
    Kurze Angaben
    The sum of £1 and any other sum or sums which are from time to time deposited in an account with the bank of scotland under account no.0044010. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 26. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of floating charge
    Erstellt am 21. Mai 1996
    Geliefert am 05. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 21ST may 1996
    Kurze Angaben
    The undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Catamount Thetford Corporation
    Transaktionen
    • 05. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. März 1994
    Geliefert am 06. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 28TH march 1994 being that part of the respective liabilities described above which exceeds the principal amount of £500,000
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Foster Wheeler Energy Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0