EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02595962 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit Bt 95/2 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9NX North, Stanley County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHROMEX (NORTH EAST) LIMITED | 30. Apr. 1991 | 30. Apr. 1991 |
| KEEPJOINT LIMITED | 27. März 1991 | 27. März 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark David Hutchinson am 30. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Charles David | Sekretär | Planetrees Wall NE46 4EQ Hexham Northumberland | British | 78876890002 | ||||||
| BROOKS, Charles David | Geschäftsführer | Planetrees Wall NE46 4EQ Hexham Northumberland | England | British | 78876890002 | |||||
| HUTCHINSON, Mark David | Geschäftsführer | 15 Larkspur Close TS26 0WD Bishop Cuthbert Hartlepool | United Kingdom | British | 66723660002 | |||||
| STANLEY, Roy Robert Edward | Geschäftsführer | 16 Graham Park Road Gosforth NE3 4BH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 8609980002 | |||||
| BORRELL, Arthur James Peter | Sekretär | Pinedale Wallace Avenue NE16 4SX Whickham County Durham | British | 47328860003 | ||||||
| HARRISON, Irene Lesley | Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff | British | 39878290001 | ||||||
| ROBINSON, Timothy Philip | Sekretär | Stanegates Leazes Lane NE46 3BA Hexham | British | 18158790003 | ||||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Sekretär | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| WARD, David | Sekretär | 69 Langdale Way The Pastures NE36 0UF East Boldon Tyne & Wear | British | 79459910001 | ||||||
| YOUNG, Ronald Desmond | Sekretär | 42 Commissioners Wharf NE29 6DN North Shields Tyne & Wear | British | 67962880001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CLARK, Andrew Philip | Geschäftsführer | 4 West Farm North Road NE36 0DQ East Boldon Tyne & Wear | British | 73633070001 | ||||||
| GORDON, Jennifer | Geschäftsführer | The Old School Church Lane NE44 6DS Riding Mill Northumberland | British | 72057320004 | ||||||
| ROBINSON, Timothy Philip | Geschäftsführer | Stanegates Leazes Lane NE46 3BA Hexham | United Kingdom | British | 18158790003 | |||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Geschäftsführer | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Geschäftsführer | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| THOMPSON, Keith Fulton Scott | Geschäftsführer | 22 Linden Way Ponteland NE20 9DP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 11845980001 | ||||||
| WARD, David | Geschäftsführer | 69 Langdale Way The Pastures NE36 0UF East Boldon Tyne & Wear | British | 79459910001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture (including qualifying floating charge) | Erstellt am 19. Mai 2005 Geliefert am 28. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 20. Nov. 2002 Geliefert am 25. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Yamazaki mazak horizontal machining centre H500-5ON, 126734 - 336,043 - 204,006, (for details of further chattels charged please refer to form 395), the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, the full benefit of all agreements, the intellectual property rights, the full benefit of the companys rights and interests in and to all insurance effected by the company or by any person of the mortgaged chattels or the use thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 29. Okt. 2001 Geliefert am 31. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £419,703 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Kurze Angaben 1 x used tooling package comprising pentium computer & accessories multiplex 625 126873 multiplex 625 126876 quick turn 30. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Juni 2001 Geliefert am 28. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 1999 Geliefert am 01. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 28. Sept. 1999 Geliefert am 02. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over the goods listed in schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 07. Okt. 1991 Geliefert am 11. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0