EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED

EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02595962
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit Bt 95/2
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9NX North, Stanley
    County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHROMEX (NORTH EAST) LIMITED30. Apr. 199130. Apr. 1991
    KEEPJOINT LIMITED27. März 199127. März 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 30. Mai 2012

    • Kapital: GBP 200,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    24 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mark David Hutchinson am 30. März 2010

    2 SeitenCH01

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    24 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    25 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    30 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Sekretär
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    British78876890002
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish78876890002
    HUTCHINSON, Mark David
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    Geschäftsführer
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    United KingdomBritish66723660002
    STANLEY, Roy Robert Edward
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish8609980002
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Sekretär
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    British47328860003
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    Sekretär
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    British39878290001
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Sekretär
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    British18158790003
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Sekretär
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    YOUNG, Ronald Desmond
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    Sekretär
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    British67962880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLARK, Andrew Philip
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    British73633070001
    GORDON, Jennifer
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    British72057320004
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Geschäftsführer
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    United KingdomBritish18158790003
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    THOMPSON, Keith Fulton Scott
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British11845980001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All assets debenture (including qualifying floating charge)
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 28. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 28. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 20. Nov. 2002
    Geliefert am 25. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Yamazaki mazak horizontal machining centre H500-5ON, 126734 - 336,043 - 204,006, (for details of further chattels charged please refer to form 395), the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, the full benefit of all agreements, the intellectual property rights, the full benefit of the companys rights and interests in and to all insurance effected by the company or by any person of the mortgaged chattels or the use thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 29. Okt. 2001
    Geliefert am 31. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £419,703 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Kurze Angaben
    1 x used tooling package comprising pentium computer & accessories multiplex 625 126873 multiplex 625 126876 quick turn 30. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Udt Limited
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2001
    Geliefert am 28. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 1999
    Geliefert am 01. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 28. Sept. 1999
    Geliefert am 02. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the goods listed in schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Udt Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1991
    Geliefert am 11. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0