MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02598875 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KPMG RESTRUCTURING 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CENTRAL POWER (HPL) LIMITED | 26. Juli 1994 | 26. Juli 1994 |
C.P. (THREE) LIMITED | 09. Juni 1994 | 09. Juni 1994 |
HAMPSHIRE MASS ENERGY LIMITED | 03. Mai 1991 | 03. Mai 1991 |
GREENRANGE LIMITED | 08. Apr. 1991 | 08. Apr. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:- replacement of liquidator | 9 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Westwood Way Westwood Business Park Coventry CV4 8LG am 22. Jan. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Ernennung von Ms Deborah Gandley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von E.on Uk Secretaries Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von E.on Uk Directors Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON UK SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | 65676600010 | |||||||
GANDLEY, Deborah | Geschäftsführer | Salisbury Square EC4Y 8BB London 8 | England | British | Solicitor | 96891580001 | ||||
BROWNE, Robert Harvey | Sekretär | 41 Western Road West Hagley DY9 0JY Stourbridge West Midlands | British | Company Solicitor | 61805140001 | |||||
ELCOCK, Ian | Sekretär | The Lodge Blakeshall Wolverley DY11 5XW Kidderminster Worcestershire | British | 72862100001 | ||||||
HAMILTON, Hugh Campbell, Mr. | Sekretär | 3 St Augustines Close WR9 8QW Droitwich Worcestershire | British | 3512530001 | ||||||
LAWTON, Jill | Sekretär | 8 Greenswood Bearley CV37 0SU Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 53543050001 | ||||||
MBC SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000700001 | |||||||
BACON, Donald George | Geschäftsführer | 544 King Edwards Wharf Sheepcote Street B16 8AB Birmingham | Canadian | Ceo | 81930330002 | |||||
BHATT, Sudhir Bhudev Prasad | Geschäftsführer | 5 Sharpe Way Narborough LE19 2RE Leicester | England | British | Senior Commercial Manager | 96076610001 | ||||
BROWNE, Robert Harvey | Geschäftsführer | 41 Western Road West Hagley DY9 0JY Stourbridge West Midlands | British | Company Solicitor | 61805140001 | |||||
BRYANT, John | Geschäftsführer | 105 Home Park Road Wimbledon SW19 7HT London | England | British | Generation Director | 16812800002 | ||||
CHAPMAN, Peter Lawton | Geschäftsführer | 4 Ashleigh Road B91 1AE Solihull West Midlands | British | Finance Director | 3512540001 | |||||
DEGG, Garry William | Geschäftsführer | 94 Finstall Road Finstall B60 3DB Bromsgrove Worcestershire | British | Operations Director | 3512550002 | |||||
HAMILTON, Hugh Campbell, Mr. | Geschäftsführer | 3 St Augustines Close WR9 8QW Droitwich Worcestershire | United Kingdom | British | Chartered Sec | 3512530001 | ||||
HUGHES, Michael Alan, Professor | Geschäftsführer | The Chapel House Binton CV37 9TN Stratford Upon Avon | England | British | Chief Executive | 3512560005 | ||||
KING, Stephen Anthony | Geschäftsführer | Hawthorn House Main Street MK18 2HT Adstock Buckinghamshire | British | Group Finance Director | 75463860002 | |||||
LAWTON, Jill | Geschäftsführer | 8 Greenswood Bearley CV37 0SU Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Solicitor | 53543050001 | |||||
LITTLEY, Andrew Jonathan | Geschäftsführer | Cherrywood Brake Lane DY8 2XW Hagley West Midlands | British | Group Accounting Manager | 37840830002 | |||||
MILLER, Michael Roy | Geschäftsführer | 135 Kingsley Road DY6 9RU Kingswinford West Midlands | British | Development Manager-Mpi | 43846500001 | |||||
POULTON, William Andrew John | Geschäftsführer | Seatstone Lodge Kings Road WR14 4HL Malvern Wells Worcestershire | British | Manager | 48495730001 | |||||
REDFEARN, David | Geschäftsführer | 17 Whitford Drive B90 4YG Solihull West Midlands | British | Development Manager | 61863580001 | |||||
SCOINS, Colin Roger | Geschäftsführer | 54 Saint Bernards Road B92 7BA Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Head Of Asian Asset Management | 78429520001 | ||||
STEVENSON, David | Geschäftsführer | 36 Needhill Close Knowle B93 9QS Solihull West Midlands | British | Solicitor | 68318870001 | |||||
TAYLOR, Philip Jonathan | Geschäftsführer | Halfway Foley Terrace WR14 4RQ Malvern Worcestershire | United Kingdom | British | Generation Development Manager | 33556640001 | ||||
TOWNSEND, Bryan Sydney | Geschäftsführer | 73 Hither Green Lane Abbey Park B98 9BN Redditch Worcestershire | British | Chairman And Chief Executive | 3512580001 | |||||
TURK, Andrew Mark | Geschäftsführer | Thatchbrook Sambourne Lane B96 6PA Sambourne Warwickshire | British | Director | 76670610001 | |||||
WRIGHT, Paul Arthur | Geschäftsführer | 16 Himley Lane Himley DY3 4LN Dudley West Midlands | British | Director Of Finance | 73124490001 | |||||
YOUNG, Richard Keith | Geschäftsführer | 58 Battenhall Road WR5 2BP Worcester Worcestershire | British | Managing Director | 67107270001 | |||||
E.ON UK DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | 85049020006 | |||||||
E.ON UK SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | 65676600010 | |||||||
MBC NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000690001 |
Hat MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Intercreditor agreement | Erstellt am 21. Nov. 1996 Geliefert am 04. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Under and subject to clause 10 (proceeds of enforcement of security) of the intercreditor agreement, amounts paid to the chargee under the provsions referred to in the "short particulars of all the property mortgaged or charged" shall be applied against the following liabilities: (a) all cost, charges, expenses and liabilities (and all interest thereon as provided in the bank security) incurred by or on behalf of the facility agent or (subject to certain conditions) the lessor and any receiver or attorney, in each case, in connection with carrying out or puporting to carry out its duties and exercising its powers and discretions under the intercreditor agreement and the bank security or, as the case may be, the lessor security and the remuneration of every receiver under the bank security or, as the case may be, the lessor security; (b) the lessor debt; (c) the bank debt; and (d) any secured liabilities not referred to in paragraphs (a)-(c) (inclusive) above. | |
Kurze Angaben The intercreditor agreement provides that: (a) if at any time the company receives a payment (including by set-off) or distribution or cash or in kind of, or on account of, any of the junior debt other than a permitted junior payment, the company will hold the same in trust for and pay or distribut it upon demand to thesecurity trustee for appliction in accordance with clause 10 (proceeds of enforcement of security) of the intercreditor agreement; and (b) if: (I) any resolution is passed or order made for the winding up, liquidation, dissolution or administration of a borrower. (Ii) a borrower assigns its assets for the benefit of its creditors or enters into any arrangement with its creditors generally, the, until the later of the bank discharge date and the lessor discharge date, the company will: (a) hold all distributions in cash or in kind received or receivable by it in respect of the junior debt in trust for and pay and distribute it upon demand to the security trustee for application in accordance with clause 10 (proceeds of enforcement of security) of the intercreditor agreement;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Intercreditor agreement | Erstellt am 22. Sept. 1994 Geliefert am 06. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee a). All costs charges expenses and liabilities (and all interest thereon as provided in the bank security) incurred by onbehalf of the facility agent or (subject to certain conditions) the lessor and any receiver or attorney in each case in connection with carrying out or purporting to carry out its duties and exercising its powers and discretions under the intercreditor agreement and the bank security or, as the case may be, the lessor security and the remuneration of every reciever under the bank security or, as the case may be, the lessor security.b).the lessor debt; the bank debt and; any secured liabilities not referred to in paragraphs (a)-(c) | |
Kurze Angaben All monies under the junior debt other than a permitted junior payment to the security trustee under clause 10 of the intercreditor agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat MIDLANDS POWER (HPL) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0