CH (CAMBRIDGE) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CH (CAMBRIDGE) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02601543 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CH (CAMBRIDGE) LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich CH (CAMBRIDGE) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Ke Developments Ltd, The Mount, Toft CB23 2RL Cambridge Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CH (CAMBRIDGE) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CATHODEON HOLDINGS LIMITED | 05. Juli 1991 | 05. Juli 1991 |
NOTSALLOW TWENTY-FIVE LIMITED | 15. Apr. 1991 | 15. Apr. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CH (CAMBRIDGE) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CH (CAMBRIDGE) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Feb. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von CH (CAMBRIDGE) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Ian David | Sekretär | Home Close Histon CB24 9JL Cambridge 59 Cambridgeshire | British | Director | 95281640003 | |||||
SMITH, Ian David | Geschäftsführer | Home Close Histon CB24 9JL Cambridge 59 Cambridgeshire | United Kingdom | British | Director | 95281640003 | ||||
WARDALL, Grahame Laurence | Geschäftsführer | Woodcote Cricket Meadow, Stradishall CB8 8YX Newmarket Suffolk | England | British | Company Director | 15703740002 | ||||
DE CHENU, Nicholas Roger Francis | Sekretär | 11 Babraham Road CB2 2RB Cambridge | British | 18380520001 | ||||||
SAUNDERS, Jane Ann | Sekretär | 35-37 Moulsham Street CM2 0HY Chelmsford Essex | British | 4679080001 | ||||||
THROWER, Trevor Peter | Sekretär | Rivendell 3 Papeley Meadow Barrow IP29 5DL Bury St Edmunds Suffolk | British | Group Managing Director Instrumentation | 6162660001 | |||||
FRIEDMANN, David | Geschäftsführer | 77-34 Austin Street Forest Hills FOREIGN New York 11375 Usa | Usa | Company Director | 26991670001 | |||||
THROWER, Trevor Peter | Geschäftsführer | Sheerwood House Hargrave Road Chevington IP29 5QR Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Group Managing Director | 158230080001 | ||||
WILDE, Alistair Peter | Geschäftsführer | 35/37 Moulsham Street CM2 0HY Chelmsford Essex | British | Commercial Manager | 6753330001 |
Hat CH (CAMBRIDGE) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 06. Apr. 1998 Geliefert am 16. Apr. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1 and 2 exeter road industrial estate hameldown road okehampton devon. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 08. Feb. 1994 Geliefert am 15. Feb. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 11. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 09. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures (see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 09. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (see form 395 for full details) including trad fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 02. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0