TEREX LIFTING U.K. LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TEREX LIFTING U.K. LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02602451 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
- Herstellung von Hebe- und Handhabungsgeräten (28220) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MATBRO LIMITED | 16. Aug. 1991 | 16. Aug. 1991 |
| FORAY 292 LIMITED | 17. Apr. 1991 | 17. Apr. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Juni 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. Juni 2017
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von John Daniel Sheehan als Direktor am 27. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Patrick Bradley als Geschäftsführer am 27. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ronald Matthew Defeo als Geschäftsführer am 11. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kevin Patrick Bradley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Phillip Widman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ronald Matthew Defeo am 17. Apr. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHEN, Eric I | Sekretär | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | American | 65582430009 | ||||||
| COHEN, Eric I | Geschäftsführer | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | United States | American | 65582430009 | |||||
| SHEEHAN, John Daniel | Geschäftsführer | 200 Nyala Farm Road 06880 Westport C/O Terex Corporation Usa | United States | American | 226001330001 | |||||
| BROOKES, Howard Maurice | Sekretär | 14 Ryknild Close Four Oaks B74 4UP Sutton Coldfield West Midlands | British | 662930001 | ||||||
| HARRIS, Andrew David | Sekretär | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| MANDERS, Douglas Nigel | Bevollmächtigter Sekretär | 44 Beebee Road WS10 9RX Wednesbury West Midlands | British | 900003700001 | ||||||
| APUZZO, Joseph | Geschäftsführer | 190 Sturges Ridge Road Wilton Fairfield 06897 Usa | American | 66269020001 | ||||||
| BAILLIE, Fergus Cumming | Geschäftsführer | 4 Abinger Gardens Murrayfield EH12 6DE Edinburgh Scotland | British | 924340002 | ||||||
| BRADLEY, Kevin Patrick | Geschäftsführer | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle United Kingdom | Untied States Of America | American | 176590390001 | |||||
| COSGROVE, Barry | Geschäftsführer | 11 Adair Avenue BT80 8PU Cookstown County Tyrone Northern Ireland | British | 13991920001 | ||||||
| CRAIG, John Egwin | Geschäftsführer | Saxonbury House Frant TN3 9HJ Tunbridge Wells Kent | British | 15697900001 | ||||||
| DEFEO, Ronald Matthew | Geschäftsführer | Beachside Avenue Westport 45 Connecticut 06880 Usa | United States | American | 94656950001 | |||||
| DOOEY, Hugh Pat | Geschäftsführer | 14 Usnastraine Road BT71 5DE Coalisland Tyrone N Ireland | Northern Ireland | Irish | 115095900001 | |||||
| HARRIS, Andrew David | Geschäftsführer | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| HARRIS, Andrew David | Geschäftsführer | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| HOLMES, Edward | Geschäftsführer | Rushford House Rushford Bridge GL12 8JW Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 55964730001 | ||||||
| KENNERLEY, John Frank William | Geschäftsführer | Old Westwick Chantry View Road GU1 3XW Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69793560001 | |||||
| MANDERS, Douglas Nigel | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 44 Beebee Road WS10 9RX Wednesbury West Midlands | British | 900003700001 | ||||||
| MCGRATH, Brendan | Geschäftsführer | 13 Newent Close Winyates Green B98 0QW Redditch Worcestershire | Irish | 38927470001 | ||||||
| MCKEOWN, Shay | Geschäftsführer | 41 Tullycullion Road Dungannon County Tyrone Northern Ireland | Irish | 40247040001 | ||||||
| MURCHAN, Seamus Michael | Geschäftsführer | 2 Ferndale Clonallon Road BT34 3FE Warrenpoint County Down | Northern Ireland | Northern Irish | 182530670001 | |||||
| NICHOLSON SMITH, James Timothy | Geschäftsführer | Kings Farm Stockwell Lane, Woodmancote GL52 4QB Cheltenham Gloucestershire | British | 70851540001 | ||||||
| NOONE, Liam | Geschäftsführer | 121 Malmesbury Road SN15 1PZ Chippenham Wiltshire | Irish | 47114340001 | ||||||
| REES, Andrew Merfyn | Geschäftsführer | 114 Vivian Road Harborne B17 0DJ Birmingham West Midlands | British | 3425330001 | ||||||
| RICE, Michael Joseph | Geschäftsführer | The Street GL9 1HH Acton Turville Greenfields Gloucestershire | United Kingdom | British | 140087640001 | |||||
| ROBERTSON, Colin | Geschäftsführer | 4 Leemuir View ML8 4AN Carluke South Lanarkshire | British | 77076440001 | ||||||
| WATSON, Hubert John | Geschäftsführer | 20 Victoria Grove Dollingstown Lurgan BT66 7JJ Craigavon County Armagh | British | 56996050003 | ||||||
| WIDMAN, Phillip Charles | Geschäftsführer | 25 Old Stone Crossing West Simsbury Connecticut 06092 Usa | Usa | American | 144249950001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TEREX LIFTING U.K. LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerscreen International (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TEREX LIFTING U.K. LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge on book and other debts | Erstellt am 16. Mai 2002 Geliefert am 23. Mai 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 04. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 04. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 04. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 04. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 04. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 26. März 1998 Geliefert am 16. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the governor and company of the bank of ireland as security trustee for the banks ("the secured parties") all monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them whether collectively or individually by the company either alone or jointly with any person or company on any account under the terms and conditions as defined in the composite debenture | |
Kurze Angaben A fixed charge over all the companys f/h and l/h lands hereditaments, premises, property and chattels both present and future including the property particulars of which are specified under the company's name in the second schedule hereto and all the company's interests in all buildings, fixtures (including, without limitation, trade fixtures) and the fixed plant and machinery from time to time thereon; all present and future plant machinery vehicles fixtures implements utensils and equipment, all goodwill and uncalled capital and all debts; floating charge over the book debts undertaking and all other property assets and rights whatsoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0