BRITSHIP FOUR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITSHIP FOUR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02606797
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITSHIP FOUR LIMITED?

    • (6110) /

    Wo befindet sich BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLUE STAR LINE (NORTH AMERICA) LIMITED06. Dez. 199606. Dez. 1996
    BLUE STAR (NORTH AMERICA) LIMITED15. Okt. 199215. Okt. 1992
    BLUE STAR PACE LIMITED30. Aug. 199130. Aug. 1991
    VALUEMODEL LIMITED01. Mai 199101. Mai 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Maersk House Braham Street London E1 8EP am 22. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 14. Okt. 2010

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von James Burridge als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Martyn Clive Allen als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 29. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    1 SeitenMG02

    legacy

    1 SeitenMG02

    legacy

    1 SeitenMG02

    legacy

    1 SeitenMG02

    Änderung der Details des Sekretärs für John Kilby am 22. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für John Kilby am 22. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed blue star line (north america) LIMITED\certificate issued on 23/07/09
    2 SeitenCERTNM

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Sekretär
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    British76247880001
    ALLEN, Martyn Clive
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Geschäftsführer
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    United KingdomBritish117739980001
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Geschäftsführer
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    EnglandBritish76247880001
    BECKETT, Geoffrey John
    48 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    Sekretär
    48 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    British1964450001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Sekretär
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Sekretär
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    WALKERLEY, Dennis John
    18 Paddock Close
    Nobles Green Eastwood
    SS9 5QR Leigh On Sea
    Essex
    Sekretär
    18 Paddock Close
    Nobles Green Eastwood
    SS9 5QR Leigh On Sea
    Essex
    British73793480001
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Sekretär
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Geschäftsführer
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Geschäftsführer
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    United KingdomBritish7865940001
    COLLINS, John Alexander, Sir
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    Geschäftsführer
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    British53032980001
    COOKE, Anthony Roderick Chichester Bancroft
    Poland Court
    RG29 1JL Odiham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Poland Court
    RG29 1JL Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish5503780001
    COOPER, Robert Hamilton
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish11632250002
    CORNTHWAITE, Christopher John
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish34530990002
    HABGOOD, David John Cecil
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29831660001
    HAZLITT, Basil Rodney
    Cousins Farm
    The Haven
    RH14 9BE Nr.Billingshurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Cousins Farm
    The Haven
    RH14 9BE Nr.Billingshurst
    West Sussex
    British1594150002
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Geschäftsführer
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    RANKIN, Christopher John
    535 East 86th Apt 19a
    10028 New York City
    New York
    United States
    Geschäftsführer
    535 East 86th Apt 19a
    10028 New York City
    New York
    United States
    British58089240001
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Geschäftsführer
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SEYMOUR, Michael John Spencer
    22 Mirabel Road
    Fulham
    SW6 7EH London
    Geschäftsführer
    22 Mirabel Road
    Fulham
    SW6 7EH London
    British17737160003
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Geschäftsführer
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WEATHERSTON, Ian Robert
    12 Chillis Wood Road
    RH16 1JT Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    12 Chillis Wood Road
    RH16 1JT Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish207360001
    WOODS, Robert Barclay
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    Geschäftsführer
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    EnglandBritish154397820001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat BRITSHIP FOUR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Subordination agreement
    Erstellt am 20. Feb. 1997
    Geliefert am 07. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or owing by the company and/or any of the other companies named therein to the senior creditors (as defined therein) under or in connection with the senior finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All payments in cash or in kind in respect of the subordinated debt (as defined therein), and any payment in respect of any security interest or under any guarantee thereunder and payments on account of the purchase or other acquisition thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for Itself and the Seniorcreditors)
    Transaktionen
    • 07. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares pledge
    Erstellt am 20. Feb. 1997
    Geliefert am 10. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and each obligor pursuant to the terms of the finance documents or any other document evidencing or security for any such liabilities
    Kurze Angaben
    Its whole right title and interes and benefit in and to the pledged securities and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Finance Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 10. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenants
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the guarantee the mortgage this deed and the other security documents
    Kurze Angaben
    The vessel and the insurances the earnings and requisition compensation the vessel means the M.V. "sydney star". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung
    • 03. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second assignment of insurances
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment and the other security documents to which the company is a party
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the insurances relating to the vessel "sydney star". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung
    • 03. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    • 03. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second priority bahamian statutory ship mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a second priority deed of covenants dated 23RD december 1993 and two demise charterparties both dated 30TH september 1993 and regulated by a guarantee dated 23RD december 1993 to be amended supplemented and/or varied from time to time
    Kurze Angaben
    The M.V. "sydney star" registered with official no 343036.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority bahamian statutory mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a second priority deed of covenants dated 23RD december 1993 and two demise charterparties both dated 30TH september 1993 and regulated by a guarantee dated 23RD december 1993 to be amended supplemented and/or varied from time to time
    Kurze Angaben
    Motor vessel "america star" official no 341451.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 27. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second assignment
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment the charterparties and the other security documents to which the assignor is a party
    Kurze Angaben
    All freights hire passage monies demurrage detention monies and all monies arising out of the use of the M.V. "sydney star" official no 343036.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 03. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of covenants
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment,the mortgage and the other security documents to which the company is a party
    Kurze Angaben
    The vessel M.V. "america star" ,the insurance and all benefits thereof the earnings and requisiton compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second assignment of insurances
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment and the other security documents to which the company is a party
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest in and to the insurances as defined on the reverse of the form 395 relating to M.V. "america star" official NO341456.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second assignment of earnings
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 12. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee this assignment,the charterparties and the other security documents to which the company is a party
    Kurze Angaben
    All freights hire passage monies demurrage detention monies and all other monies arising out of the use of the vessel M.V. "america star" official no 241451. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority general assignmnent
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 11. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or blue star line limited to the chargee under or pursuant to the charterparties (as defined) and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All earnings (as defined) the insurances and all requisition compensation relating to the ship "melbourne star". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority statutory mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 11. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or blue star line limited in respect of an account current regulated by the charterparties (as defined) and a deed of covenant dated 23RD december 1993 as supplemented and amended from time to time
    Kurze Angaben
    All the company's 64 64TH shares of the "melbourne star" and in her boats guns,ammunition,small arms and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority deed of covenants
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 11. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or blue star line limited to the chargee under or pursuant to the charterparties (as defined) and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest present and future in and to the ship M.V. "melbourne star". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General assignment
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 04. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $ 6,175,000 due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH january 1993 as amended by a supplemental agreement dated 23RD december 1993 and any other monies payable under the loan agreement and security docements (as defined)
    Kurze Angaben
    All monies due to the company arising out of the use of M.V. `melbourne star' all policies and contracts of insurance in respect of the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First priority bahamian statutory mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 04. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $ 6,175,000 due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH january 1993 as amended by a supplemental agreement dated 23RD december 1993 and any other monies payable under the loan agreement and security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest present and future in the M.V. `melbourne star' registered in the bahamas official number 342859.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of covenants
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 04. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $ 6,175,000 due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH january 1993 as amended by a supplemental agreement dated 23RD december 1993 and any other monies payable under the loan agreement and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's right,title and interest present and future in and to M.V. `melbourne star' registered in the bahamas official number 342859.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second reinsurance agreement assignment
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 30. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or albion insurance company limited to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the "reinsurances" (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second assignment of insurances
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 30. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and to the secured parties and to the secured parties or any of them subject to the covenants,undertakings,guarantees and agreements contained in the assignment and in any of the other security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all policies of insurance relating to the bahamian vessel M.V. "brisbane star" see form 395 M9 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second assignment of earnings
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 30. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and to the secured parties (as defined) or any of them subject to the covenants undertakings guarantees and agreements contained in the assignment and any of the other security documents as(as defined)
    Kurze Angaben
    All freights charterhire and other earnings of whatsoever nature of the company's bahamian registered vessel "brisbane star" see form 395 M8 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (As Sedcurity Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority deed of covenants
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 30. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and to the secured parties (as defined) or any of them subject to the covenants,undertakings,guarantees and agreements contained in the deed of covenants and any of the other security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the M.V.brisbane star and the insurances and all benefits thereof see form 395 M7 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 30. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority bahamian statutory ship mortgage
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 30. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and the secured parties (as defined) or any of them on an account current as regulated by the facility agreements (as defined) the guarantee and the mortgage debenture both dated 22/05/92 and a deed of covenants dated 13/07/93
    Kurze Angaben
    All 64/64TH shares in the company's bahamian registered vessel M.V. brisbane star having official number 723468 and all benefits relating thereto see form 395 M6 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An assignment agreement
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 21. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12/07/93 and/or under the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The earnings being all freight,hire and any other amounts which may be earned or payable to or for the account of the company or their agents arising from ownership of the ship and the insurances of the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenant
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 21. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12/07/93 and/or under the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    M.V. "brisbane star" registered in the port of nassau under official no:723468 including any share or interest therein and the hull,machinery and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First statutory mortgage
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 21. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of the facility letter dated 12/07/93 and/or the security documents (as defined) and/or the deed of covenants
    Kurze Angaben
    M.V. "brisbane star" registered in the name of the company at the port of nassau under official no:723468 including any share or interest therein and the hull,machinery and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority deed of covenants
    Erstellt am 26. Mai 1992
    Geliefert am 10. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (in it's capacity as security trustee under the assignment and in it's capacity as the co-ordinator under an overrideagreement dated 220592)and all or any of the lenders named therein on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest present and future in the bahamian flag vessel "queensland star" see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BRITSHIP FOUR LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Okt. 2010Beginn der Liquidation
    19. Aug. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praktiker
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0