LANBASE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLANBASE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02617729
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LANBASE LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LANBASE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LANBASE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STAKEPROFIT PUBLIC LIMITED COMPANY05. Juni 199105. Juni 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LANBASE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LANBASE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LANBASE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 30. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    3 SeitenMR04

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Juni 2015

    • Kapital: GBP 50,100
    SH01

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 13. Juni 2014

    • Kapital: GBP 50,100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von LANBASE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151233190001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BERRY, Alfred Joseph
    27 Saffron Close
    RG14 1XD Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    27 Saffron Close
    RG14 1XD Newbury
    Berkshire
    British53652360001
    BERRY, Keith Joseph
    12 Donnington Square
    RG14 1PJ Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    12 Donnington Square
    RG14 1PJ Newbury
    Berkshire
    British69839540002
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    NEEDS, Leslie John
    Bittern Close
    RG22 5JA Basingstoke
    24
    Hampshire
    Sekretär
    Bittern Close
    RG22 5JA Basingstoke
    24
    Hampshire
    British87597350001
    SUGDEN, Dawn Priscilla
    48 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LT Oakham
    North Cottage
    Leicestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    48 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LT Oakham
    North Cottage
    Leicestershire
    United Kingdom
    British131370800001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BERRY, Alfred Joseph
    27 Saffron Close
    RG14 1XD Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    27 Saffron Close
    RG14 1XD Newbury
    Berkshire
    British53652360001
    BERRY, Keith Joseph
    12 Donnington Square
    RG14 1PJ Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    12 Donnington Square
    RG14 1PJ Newbury
    Berkshire
    British69839540002
    BERRY, Keith Joseph
    Copt Heath
    Hermitage Road, Cold Ash
    RG18 9JN Thatcham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Copt Heath
    Hermitage Road, Cold Ash
    RG18 9JN Thatcham
    Berkshire
    British70668960001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CHAPPLE, Graham
    1 Harts Hill Road
    Thatcham
    RG13 3QP Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Harts Hill Road
    Thatcham
    RG13 3QP Newbury
    Berkshire
    British56827220001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GRAFIN VON BROCKDORFF AHLFELDT, Claire Louise Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish166267770001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KENT, Steve James
    Falling Water House
    Staploe
    PE19 5JA St Neots
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Falling Water House
    Staploe
    PE19 5JA St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish88968260004
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    NEEDS, Leslie John
    Bittern Close
    RG22 5JA Basingstoke
    24
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bittern Close
    RG22 5JA Basingstoke
    24
    Hampshire
    United KingdomBritish87597350001
    RICHTER, Bret
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    Geschäftsführer
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    American86830760001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Geschäftsführer
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Geschäftsführer
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    SCHUBERT, Scott Elliott
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    Geschäftsführer
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    American89618040001
    SWAN, Peter
    58 Harwood Rise
    Woolton Hill
    RG15 9XZ Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    58 Harwood Rise
    Woolton Hill
    RG15 9XZ Newbury
    Berkshire
    British19517250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    VAUGHAN, Andrew
    19 The Badgers Mearse Lane
    Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Geschäftsführer
    19 The Badgers Mearse Lane
    Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British43301470002

    Hat LANBASE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charges all right, title and interest in: 1) the english charged land 2) the tangible moveable property 3) the accounts 4) the intellectual property 5) any goodwill 6) the investments 7) the shares and all dividends 8) all monetary claims by way of assignment all right, title and interest in: 1) any insurance policy 2) all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings 3) chattels hired, leased or rented 4) licences held, by way of floating charge the whole undertaking and assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as second security trustee for the secured parties (the "second security trustee")
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 23. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Nov. 1998
    Geliefert am 09. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Okt. 1991
    Geliefert am 21. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 16/8/88
    Kurze Angaben
    Rent deposit being the sum of £33,500.
    Berechtigte Personen
    • Airspace Investments Limited.
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Sept. 1991
    Geliefert am 02. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 22. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0