THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED

THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02620374
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED?

    • (5530) /

    Wo befindet sich THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    21 Loudoun Road
    London
    NW8 0NB
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis27. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. März 2011

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2010

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Sept. 2011

    Kapitalaufstellung am 01. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 99,918
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2009

    16 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2007

    5 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten395

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HILL, John Rupert Crassweller
    1 Rylett Crescent
    W12 9RP London
    Sekretär
    1 Rylett Crescent
    W12 9RP London
    British74240800003
    DE FAZIO, Raymond Alexander Patrick
    55 Compayne Gardens
    West Hampstead
    NW6 3DB London
    Geschäftsführer
    55 Compayne Gardens
    West Hampstead
    NW6 3DB London
    EnglandBritish77707490003
    HILL, John Rupert Crassweller
    1 Rylett Crescent
    W12 9RP London
    Geschäftsführer
    1 Rylett Crescent
    W12 9RP London
    United KingdomBritish74240800003
    BREWSTER, Timothy
    Haven Wenlock Basin Wharf Road
    Islington
    N1 6RX London
    Sekretär
    Haven Wenlock Basin Wharf Road
    Islington
    N1 6RX London
    British81651180001
    HOARE, Julia
    18 St Saviours Wharf
    Mill Street
    SE1 2BE London
    Sekretär
    18 St Saviours Wharf
    Mill Street
    SE1 2BE London
    British72462080001
    SHAW, Ian Gerald
    Brockhampton Gate
    Buckland Newton
    DT2 7DJ Dorchester
    Dorset
    Sekretär
    Brockhampton Gate
    Buckland Newton
    DT2 7DJ Dorchester
    Dorset
    British85480530001
    SHAW, Ian
    40 Wellington Street
    WC2E 7BD London
    Sekretär
    40 Wellington Street
    WC2E 7BD London
    British66873600001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BLACKWOOD, David James
    2 Cotswold Way
    EN2 7HJ Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Cotswold Way
    EN2 7HJ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish64112380001
    BREWSTER, Tim Michael
    Haven Wenlock Basin
    Wharf Road
    N1 7RX London
    Geschäftsführer
    Haven Wenlock Basin
    Wharf Road
    N1 7RX London
    British63534330002
    CLARKE, Susan Elizabeth
    40 Wellington Street
    WC2E 7BD London
    Geschäftsführer
    40 Wellington Street
    WC2E 7BD London
    British50203080002
    HAMPTON, Jonathan David
    67 River View Grove
    Chiswick
    W4 3QP London
    Geschäftsführer
    67 River View Grove
    Chiswick
    W4 3QP London
    British22228390002
    HARRISON, Karl David
    Ower Quay Cottage
    Corfe Castle
    BH20 5JN Wareham
    Dorset
    Geschäftsführer
    Ower Quay Cottage
    Corfe Castle
    BH20 5JN Wareham
    Dorset
    United KingdomBritish69607190006
    HERON, Deborah Jane
    6 Sycamore Avenue
    Oakridge Point
    BB9 0ND Nelson
    Lancashire
    Geschäftsführer
    6 Sycamore Avenue
    Oakridge Point
    BB9 0ND Nelson
    Lancashire
    British51872410003
    HOARE, Julia
    18 St Saviours Wharf
    Mill Street
    SE1 2BE London
    Geschäftsführer
    18 St Saviours Wharf
    Mill Street
    SE1 2BE London
    British72462080001
    LAMANI, Stephane
    8 Bow Street
    Covent Garden
    WC2E 7AJ London
    Geschäftsführer
    8 Bow Street
    Covent Garden
    WC2E 7AJ London
    French82538070001
    LAMBERT, Peter
    357 King Henrys Drive
    New Addington
    CR0 0AF Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    357 King Henrys Drive
    New Addington
    CR0 0AF Croydon
    Surrey
    British15380550001
    ROBERTSON, James Anthony
    4th Floor
    59 Old Compton Street
    W1D 6HP London
    Geschäftsführer
    4th Floor
    59 Old Compton Street
    W1D 6HP London
    British109416370001
    SCOTT, Jonathan James
    The Observatory Pinnacle House
    260 Old Oak Common Lane
    NW10 6DX London
    Geschäftsführer
    The Observatory Pinnacle House
    260 Old Oak Common Lane
    NW10 6DX London
    British42996280003
    SHAW, Ian Gerald
    Brockhampton Gate
    Buckland Newton
    DT2 7DJ Dorchester
    Dorset
    Geschäftsführer
    Brockhampton Gate
    Buckland Newton
    DT2 7DJ Dorchester
    Dorset
    British85480530001
    SHAW, Ian
    40 Wellington Street
    WC2E 7BD London
    Geschäftsführer
    40 Wellington Street
    WC2E 7BD London
    British66873600001
    SHAW, Martin
    36 Deerpark Road
    BB10 4SD Burnley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    36 Deerpark Road
    BB10 4SD Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish51872310002
    SHAW, Teresa Rose
    25 Coronation Road
    Brierfield
    BB9 5BS Nelson
    Lancashire
    Geschäftsführer
    25 Coronation Road
    Brierfield
    BB9 5BS Nelson
    Lancashire
    United KingdomBritish103962190001
    SHAW, Veronica Maureen
    122 Halifax Road
    BB9 5BQ Brierfield
    Lancashire
    Geschäftsführer
    122 Halifax Road
    BB9 5BQ Brierfield
    Lancashire
    British51604680001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of substitution
    Erstellt am 31. Mai 2012
    Geliefert am 20. Juni 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H ground floor and basement 59 old compton street london with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 20. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Nov. 2007
    Geliefert am 17. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 36-40 wellington st,covent garden london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 13. Nov. 2007
    Geliefert am 15. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (For details of properties charged pleas. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Cash deposit deed
    Erstellt am 22. Juni 2005
    Geliefert am 25. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Deposit £17,500. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norman and Susan Mandell
    Transaktionen
    • 25. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 09. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 38 wellington street london,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 02. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    36 wellington street london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 02. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    40 wellington street london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. März 2005
    Geliefert am 22. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 1996
    Geliefert am 21. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    38 wellington street covent garden l/b of city of westminster.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 1991
    Geliefert am 22. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    40 wellington st,l/b of city of westminster.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Counterpart rental deposit agreement
    Erstellt am 05. Nov. 1991
    Geliefert am 14. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Kurze Angaben
    The deposit of £18,375.
    Berechtigte Personen
    • Mecca Leisure Catering LTD
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1991
    Geliefert am 11. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat THE FOUR 'S' CORPORATION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Apr. 2014Aufgelöst am
    06. Juni 2012Antragsdatum
    30. Dez. 2013Abschluss der Liquidation
    03. Dez. 2012Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0