MEDITECH IT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MEDITECH IT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02620845 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MEDITECH IT LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MEDITECH IT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MEDITECH IT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MEDITECH REHAB LIMITED | 17. Juni 1991 | 17. Juni 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEDITECH IT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MEDITECH IT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2021 | 11 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Antony Midgley als Geschäftsführer am 15. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Jack William Edwards-Fox als Direktor am 15. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Ms Emma Claire Harvey-Kitching als Direktor am 15. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Martin Steeper als Geschäftsführer am 15. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 29. Feb. 2020 | 11 Seiten | AA | ||
Change of details for Meditech Group Limited as a person with significant control on 15. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2019 | 11 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2018 | 11 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von John Antony Midgley als Sekretär am 18. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Ms Emma Claire Harvey-Kitching als Sekretär am 18. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2017 | 10 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Antony Midgley am 24. Aug. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Mr John Antony Midgley as a person with significant control on 24. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 7 Severn Road Hunslet Leeds LS10 1BL England zum Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive Leeds LS10 1DF am 15. Aug. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MEDITECH IT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Sekretär | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | 250527680001 | |||||||
EDWARDS-FOX, Jack William | Geschäftsführer | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 279716140001 | ||||
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Geschäftsführer | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 279714040001 | ||||
CROSS, Richard Alexander | Sekretär | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | British | Company Director | 178817310001 | |||||
HOLLAMBY, John | Sekretär | Melborne House 124a Borden Lane ME9 8HR Sittingbourne Kent | British | 11350680003 | ||||||
MIDGLEY, John Antony | Sekretär | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | British | Director | 45716360002 | |||||
O CALLAGHAN, Perry Charles | Sekretär | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | British | 79595830001 | ||||||
ORAM, Stephen Marcus | Sekretär | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | British | Accountant | 57274140002 | |||||
AA COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED | Sekretär | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710002 | |||||||
CROSS, Richard Alexander | Geschäftsführer | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | Uk | British | Company Director | 178817310001 | ||||
ELLIOTT, Roy Alexander | Geschäftsführer | 22 Fiske Pightle Ipswich Road Willisham IP8 4SN Ipswich Suffolk | British | Prosthetist | 44159400001 | |||||
HOLLAMBY, John | Geschäftsführer | Melborne House 124a Borden Lane ME9 8HR Sittingbourne Kent | British | Prosthetist | 11350680003 | |||||
IVES BROWN, Geoffrey William | Geschäftsführer | 90 Broughton Road South Woodham Ferrers CM3 5FY Chelmsford Essex | British | Prosthetist | 44159310001 | |||||
JOHNSON, Robert Montague | Geschäftsführer | 12 Hamilton Terrace NW8 9UG London | British & American | Director | 17964410002 | |||||
JOYCE, Shaun William | Geschäftsführer | c/o Rsl Steeper Hunslet Trading Estate Severn Road LS10 1BL Leeds Unit 7 United Kingdom | England | British | Director | 133825540001 | ||||
MIDGLEY, John Antony | Geschäftsführer | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | United Kingdom | British | Director | 45716360003 | ||||
MILLER, Anthony Charles | Geschäftsführer | Walnut Tree Cottage Little London Combs IP14 2ES Stowmarket Suffolk | United Kingdom | British | Prosthetist | 17474200003 | ||||
O'CALLAGHAN, Perry Charles | Geschäftsführer | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | British | Accountant | 30363240003 | |||||
ORAM, Stephen Marcus | Geschäftsführer | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | England | British | Accountant | 57274140002 | ||||
PARKER, Stephen Robert | Geschäftsführer | 6 Aspen Way RM15 6TX South Ockendon Essex | British | Prosthetist | 70148000002 | |||||
PARKER, Stephen Robert | Geschäftsführer | 3 Sutton Mead CM2 6QB Chelmsford Essex | British | Prosthetist | 70148000001 | |||||
PESENTI, Stephen John Ross | Geschäftsführer | Flat 8 29 St Stephens Gardens W2 5NA London | British | Investment | 44840210001 | |||||
SHEARD, Gary, Dr | Geschäftsführer | 51 Riverside 2 Medway City Estate ME2 4DP Rochester Kent | England | British | Director | 118863590001 | ||||
SMITH, David George Osborne | Geschäftsführer | 71 Puttney Drive Kemsley ME10 2SJ Sittingbourne Kent | British | Prosthetics | 13513010001 | |||||
STEEPER, Paul Martin | Geschäftsführer | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 183358890001 | ||||
TAYLOR, James Malcolm | Geschäftsführer | Prospect House Whins Lane Wheelton PR6 8HN Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 41836630002 | ||||
THOMAS, Trevor George Corry | Geschäftsführer | 51 Riverside 2 Medway City Estate ME2 4DP Rochester Kent | England | British | Director | 15006120001 | ||||
WEBSTER, Simon Philip | Geschäftsführer | 27 Merrick Square SE1 4JB London | United Kingdom | British | Director | 30932730002 | ||||
BUYVIEW LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MEDITECH IT LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr John Antony Midgley | 06. Apr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Paul Martin Steeper | 06. Apr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Meditech Group Limited | 06. Apr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3 Stourton Link England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MEDITECH IT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 05. März 2004 Geliefert am 16. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Juli 1995 Geliefert am 09. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0