DT HOLDINGS

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDT HOLDINGS
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 02621255
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DT HOLDINGS?

    • (7415) /

    Wo befindet sich DT HOLDINGS?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DT HOLDINGS?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HANDSTART LIMITED18. Juni 199118. Juni 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DT HOLDINGS?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für DT HOLDINGS?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Juni 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    9 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    10 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von DT HOLDINGS?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCDONOUGH, James
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    Sekretär
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    U.S. Citizen117763570001
    MCDONOUGH, James
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    Geschäftsführer
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    U.S. Citizen117763570001
    COWAN, Charles Gibbs
    8 Powell Avenue
    M4W 2Y7 Toronto
    Ontario
    Canada
    Sekretär
    8 Powell Avenue
    M4W 2Y7 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian46333280001
    DAVIES, Alan John
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    British43528130002
    GRIFFITHS, Sally Jane
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    Sekretär
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    British91601070001
    PORTER, Alan Fraser
    25a Alexander Street
    W2 5NT London
    Sekretär
    25a Alexander Street
    W2 5NT London
    British39677980001
    VAN HORN, James R
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    Sekretär
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    Us Citizen127973690001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARKER III, William
    1612a N. Mohawk
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60614
    United States
    Geschäftsführer
    1612a N. Mohawk
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60614
    United States
    U.S. Citizen120001190001
    BLACK, Conrad Moffat, Lord
    14 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    Geschäftsführer
    14 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    British Canadian28193100004
    BOULTBEE, John Arthur
    37 Riverside Crescent
    M5S 1B5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    37 Riverside Crescent
    M5S 1B5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian46417990001
    COLSON, Daniel William
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Geschäftsführer
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Canadian47403810003
    COLSON, Daniel William
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Geschäftsführer
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Canadian47403810003
    COWAN, Charles Gibbs
    8 Powell Avenue
    M4W 2Y7 Toronto
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    8 Powell Avenue
    M4W 2Y7 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian46333280001
    DAVIES, Alan John
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    British43528130002
    DOVE, Anthony Charles
    59 Blackheath Park
    Blackheath
    SE3 9SQ London
    Geschäftsführer
    59 Blackheath Park
    Blackheath
    SE3 9SQ London
    British6463750001
    GRIFFITHS, Sally Jane
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    British91601070001
    HEALEY, Paul B
    210 West 9oth Street
    Apt 7j
    New York
    Ny 10024
    Us
    Geschäftsführer
    210 West 9oth Street
    Apt 7j
    New York
    Ny 10024
    Us
    Us Citizen96306870001
    LUEDER, Caroline
    Portman Gate 41 Broadley Terrace
    NW1 6LQ London
    Geschäftsführer
    Portman Gate 41 Broadley Terrace
    NW1 6LQ London
    English18149650001
    O'DONNELL KEENAN, Niamh
    142 Hampstead Way
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7XH London
    Geschäftsführer
    142 Hampstead Way
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7XH London
    Great BritainIrish57325730001
    PARIS, Gordon A
    7 Mt Holly Drive
    Rye
    Ny 10580
    America
    Geschäftsführer
    7 Mt Holly Drive
    Rye
    Ny 10580
    America
    Us Citizen96298180001
    PORTER, Alan Fraser
    25a Alexander Street
    W2 5NT London
    Geschäftsführer
    25a Alexander Street
    W2 5NT London
    British39677980001
    SCOTT, William Alexander
    12 Addison Grove
    W4 1ER London
    Geschäftsführer
    12 Addison Grove
    W4 1ER London
    Canadian43214090001
    SMITH, Robert
    194 Fairmont Avenue
    Chatham
    Nj 07928
    Usa
    Geschäftsführer
    194 Fairmont Avenue
    Chatham
    Nj 07928
    Usa
    U S Citizen96296370001
    STOKLOSA, Gregory
    1021 Forest Avenue
    Evanston
    Illinois 60202
    United States
    Geschäftsführer
    1021 Forest Avenue
    Evanston
    Illinois 60202
    United States
    U S Citizen117762260001
    VAN HORN, James R
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    Geschäftsführer
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    UsaUs Citizen127973690001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat DT HOLDINGS Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture creating fixed and floating charges
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations due or to become due from the charging company to any of the secured parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wachovia Bank,N.A.as Security Trustee
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    UK subsidiary guaranty dated 23RD december, 2002 between the guarantor, deedtask limited, creditscheme limited, second dt holdings limited, hollinger UK holdings limited (the "additional guarantors") in favour of the secured parties and wachovia bank, N.A. as adminstrative agent for the lenders (the "U.K. guarantee")
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any and all balances, credits, deposits, accounts or moneys of the guarantor then or thereafter maintained with the administrative agent or such other secured party and any and all property of every kind or description of or in the name of the guarantor now or hereafter, for any reason or purpose whatsoever, in the possession or control of, or in transits to, the administrative agent or, such other secured party or any agent or bailee therefore.
    Berechtigte Personen
    • Wachovia Bank, N.A.
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental deed to the the deed of charge and memorandum of deposit dated 7TH april 1997 as amended by the first supplemental deed dated 8TH march 2000 (the "second supplemental deed to U.K. pledge agreement") issued by the company
    Erstellt am 08. März 2000
    Geliefert am 17. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee all obligations (monetary or otherwise) of the depositor howsoever created, arising or evidenced, whether direct or indirect, absolute or contingent, existing on or after 7TH april 1997 or due or to become due which arise out of or in connection with, in the case of hollinger UK holdings limited, the UK newco subsidiary guaranty, in the case of first dt holdings limited and the depositor, the UK subsidiary guaranty and in the case of the depositor, first dt holdings limited and hollinger UK holdings limited, the charge and memorandum (as amended) (the "amended charge and memorandum"), any other loan document or any other document or instrument executed in connection there with (including any hedging agreement entered into with any person who at the time such hedging agreement is entered into is a lender or an affiliate thereof)
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to all of the shares described in schedule 1 to the amended charge and memorandum listed under the depositor's name, all of the certificates and/or instruments representing such shares and all cash securities dividends rights and other property at any time and from time to time received receivable or otherwise distributed in respect of or in exchange for any or all of the shares;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Toronto Dominion (Texas), Inc.(as Administrative Agent for the Lenders)
    Transaktionen
    • 17. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the deed of charge and memorandum of deposit dated 7 april 1997 and made between toronto dominion (texas), inc.(the administrative agent) first dt holdings limited dt holdings limited (the pledgor and hollinger international publishing inc (the supplemental deed to the UK pledge agreement)
    Erstellt am 30. Apr. 1999
    Geliefert am 18. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (monetary or otherwise of the depositor howsoever created arising or evidenced whether direct or indirect absolute or contingent existing on or after 7 april 1997 or due or ot become due which arise out of or in connection with in the case of hollinger international publishing inc, section 15 of the amended and restated credit agreement (save that for the purposes of this definition there shall be excluded therefrom any liabilities and/or obligations of hifcorp and canada holdings) in the case of first dt holdings limited and thew pledgor the UK subsidiary guaranty and in the case of hollinger international publishing inc first dt holdings limited and the pledgor the charge and memorandum (as amended) any other loan document or any other document or instrument executed in connection therewith (including any hedging agreement entered into with any person who at the time such hedging agreementis entered into is a lender or an affiliate thereto)
    Kurze Angaben
    All the rights title and interest I all of thew shares all of the certificates and/or instruments representing such shares and all cash securities dividends rights and other property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Toronto Dominion (Texas) Inc
    Transaktionen
    • 18. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge and memorandum of deposit
    Erstellt am 07. Apr. 1997
    Geliefert am 23. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee which arise out of or in connection with in the case of hollinger international publishing inc., Section 15 of the credit agreement (as defined); in the case of first dt holdings limited and dt holdings limited, the U.K. subsidiary guaranty, and in the case of each depositor, this charge and memorandum, and any other loan document (as defined) or any other document or instrument executed in connection therewith (including any hedging agreement)
    Kurze Angaben
    All of its right, title and interest in and to the following:- all of the shares described in schedule 1 to the UK pledge agreement listed under the depositor's name, all of the certificates and/or instruments representing such shares, all cash securities, dividends, rights and other property at any time and from time to time received, receivable or otherwise distributed in respect of or in exchange for any or all of such shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Toronto-Dominion (Texas), Inc.
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge and memorandum of deposit
    Erstellt am 30. Mai 1996
    Geliefert am 14. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from first dt holdings limited to the chargee under the terms of the various deeds and documents defined therein
    Kurze Angaben
    All dividends and rights in connection with the shares detailed on form 395 issued by first dt holdings limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 14. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0